Buscador CIF Logo

Actos BORME Expansion Turistica De Extremadura Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Expansion Turistica De Extremadura Sa

Actos BORME Expansion Turistica De Extremadura Sa - A10241354

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Caceres para Expansion Turistica De Extremadura Sa con CIF A10241354

馃敊 Perfil de Expansion Turistica De Extremadura Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Caceres

Actos BORME de Expansion Turistica De Extremadura Sa

23 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SLP. Datos registrales. T 842, L 669, F 105, S 8, H CC 5465, I/A 40 (10.11.23).

05 de Enero de 2023
Reelecciones. Consejero: CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DELCARMEN;PINILLA CRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente:CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN. Secretario: PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPOVALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ.Datos registrales. T 842, L 669, F 105, S 8, H CC 5465, I/A 38 (22.12.22).

26 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 842, L 669, F 105, S 8, H CC 5465, I/A 37 (16.11.20).

06 de Marzo de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.667.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.540.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: ="ARTICULO 5潞.- El capital social es de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS(1.540.000 E), representados por setenta mil acciones nominativas de veintid贸s euros cada una de ellas, numeradas del n煤mero uno alsetenta mil, ambos incluidos. Se encuentra totalmente. Datos registrales. T 842, L 669, F 105, S 8, H CC 5465, I/A 36 (19.02.20).

18 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPOVALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente: CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: PINILLAFERNANDEZ VALENTIN. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Secretario: PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO. Nombramientos. Consejero:CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLACRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente: CRESPO MARQUEZMARIA DEL CARMEN. Secretario: PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLACRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T842, L 669, F 103, S 8, H CC 5465, I/A 35 (10.07.18).

24 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 842, L 669, F 103, S 8, H CC 5465, I/A 34 ( 9.01.18).

21 de Octubre de 2015
Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 842, L 669, F 102, S 8, H CC 5465, I/A 33 (14.10.15).

12 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Nombramientos. Secretario: PINILLA CRESPOCESAR AUGUSTO. Datos registrales. T 842, L 669, F 102, S 8, H CC 5465, I/A 32 (20.04.15).

16 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZVALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Consejero:VALIENTE CANCHO FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Reelecciones.Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLACRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIABEATRIZ. Presidente: CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN. Datosregistrales. T 842, L 669, F 102, S 8, H CC 5465, I/A 30 (20.06.13).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T 842, L 669, F 102, S 8, H CC 5465, I/A 31 (20.06.13).

27 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 842, L 669, F 102, S 8, H CC 5465, I/A 29 ( 9.01.12).

27 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: PICARDO NIETO ALEJANDRO. Datos registrales. T 784, L 611, F 210, S 8, H CC 5465, I/A 28(13.05.10).

25 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Consejero: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCOLUIS;CRIADO DIAZ ANTONIO. Revocaciones. Apo.Sol.: CRIADO DIAZ ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj:CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 784, L 611, F 210, S 8, H CC 5465, I/A 27 ( 4.03.10).

05 de Junio de 2009
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MOLANO JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 784, L 611, F 197, S 8, H CC 5465, I/A26 (23.05.09).

02 de Marzo de 2009
Nombramientos. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO BEATRIZ. Datos registrales. T 784, L 611, F 195, S 8, H CC 5465, I/A 25 (14.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n