Buscador CIF Logo

Actos BORME Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada

Actos BORME Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada - B99363467

Tenemos registrados 55 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada con CIF B99363467

馃敊 Perfil de Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Explotacion Agroalimentaria Aragonesa Sociedad Limitada

13 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4578 , F 137, S 8, H Z 54231, I/A 55 ( 3.11.23).

10 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4578 , F 137, S 8, H Z 54231, I/A 54 ( 2.11.23).

10 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MILLAN ARNUELOS JULIO. Datos registrales. T 4578 , F 135, S 8, H Z 54231, I/A 51 ( 3.05.23).

Revocaciones. Apoderado: DIESTE GRACIA ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: DIESTE GRACIA ALBERTO. Datosregistrales. T 4578 , F 135, S 8, H Z 54231, I/A 52 ( 3.05.23).

Nombramientos. Apoderado: ARNAL GARCIA JESUS. Datos registrales. T 4578 , F 136, S 8, H Z 54231, I/A 53 ( 3.05.23).

02 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4578 , F 135, S 8, H Z54231, I/A 50 (26.10.22).

28 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE PALACIOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 4571 , F 99, S 8, H Z 54231, I/A 47(17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MARTIN DAVID. Datos registrales. T 4571 , F 101, S 8, H Z 54231, I/A 49 (22.02.22).

24 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO;MILLAN ARNUELOS JULIO;MILLAN ARNUELOS JULIO;LLORENTEPALACIOS JOSE MARIA;GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA;VI脩AL ROY GUILLERMO. Datos registrales. T 4571 , F 94, S 8, H Z54231, I/A 40 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 4571 , F 94, S 8, H Z 54231, I/A 41 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: TURBICA MORENA CARLOS. Datos registrales. T 4571 , F 95, S 8, H Z 54231, I/A 42 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: DIESTE GRACIA ALBERTO. Datos registrales. T 4571 , F 96, S 8, H Z 54231, I/A 43 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: ROY RAGA ANGEL. Datos registrales. T 4571 , F 97, S 8, H Z 54231, I/A 44 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: AGUSTIN GABASA LUIS. Datos registrales. T 4571 , F 98, S 8, H Z 54231, I/A 45 (17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO VICENTE JOSE-JAVIER. Datos registrales. T 4571 , F 98, S 8, H Z 54231, I/A 46(17.02.22).

Nombramientos. Apoderado: MILLAN ARNUELOS JULIO. Datos registrales. T 4571 , F 100, S 8, H Z 54231, I/A 48 (17.02.22).

14 de Febrero de 2022
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 4571 , F 94, S 8, H Z 54231, I/A 39 ( 4.02.22).

09 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4158 , F 35, S 8, H Z 54231, I/A 38 ( 2.02.22).

29 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: ESCOSA GONZALEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 4158 , F 35, S 8, H Z 54231, I/A 37(22.12.21).

20 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4158 ,F 34, S 8, H Z 54231, I/A 35 (13.10.21).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos.Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL.Cons.Del.Sol: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Cambiado el representante del consejero SA MINERACATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 4158 , F 35, S 8, H Z 54231, I/A 36 (13.10.21).

27 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4158 , F 34, S 8, H Z 54231, I/A 34 (20.07.21).

21 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: LUENGO EGIDO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: MIRANDA SIMAVILLA JUAN.Vicepresid.: LUENGO EGIDO JAVIER. Reelecciones. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4158 , F 34,S 8, H Z 54231, I/A 33 (14.06.21).

05 de Marzo de 2021
Cambio de domicilio social. C/ BILBAO 5 - LOCAL (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4158 , F 33, S 8, H Z 54231, I/A 32(26.02.21).

27 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 4158 , F 32, S 8, H Z 54231, I/A 30(20.03.20).

Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COMPA脩IA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL SA. Datos registrales. T 4158 , F33, S 8, H Z 54231, I/A 31 (20.03.20).

18 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: QUILEZ SAZ RAFAEL. Datos registrales. T 4158 , F 31, S 8, H Z 54231, I/A 28 (11.02.20).

Nombramientos. Apoderado: VI脩AL ROY GUILLERMO. Datos registrales. T 4158 , F 31, S 8, H Z 54231, I/A 29 (11.02.20).

10 de Febrero de 2020
Otros conceptos: Revocada la facultad 19陋 del poder conferido a favor de don Juan-Carlos Rituerto G贸mez, que consta en lainscripci贸n 22陋 de la hoja de la sociedad. Datos registrales. T 4158 , F 31, S 8, H Z 54231, I/A 27 ( 4.02.20).

18 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE PALACIOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 4158 , F 30, S 8, H Z 54231, I/A 26(11.06.19).

20 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: MILLAN ARNUELOS JULIO. Datos registrales. T 4158 , F 29, S 8, H Z 54231, I/A 24 (13.03.19).

Revocaciones. Apoderado: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE. Datos registrales. T 4158 , F 30, S 8, H Z 54231, I/A 25(13.03.19).

24 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4158 , F 28, S 8, H Z 54231, I/A 22(17.01.18).

Revocaciones. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4158 , F 29, S 8, H Z 54231, I/A 23(17.01.18).

11 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE. Datos registrales. T 4158 , F 27, S 8, H Z 54231, I/A 21 (4.04.17).

08 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.D.Gral.: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE. Datos registrales. T 4158 , F 27, S 8, H Z 54231, I/A 20(26.01.17).

31 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.D.Gral.: RITUERTO GOMEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4158 , F 25, S 8, H Z 54231, I/A 19(23.01.17).

26 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: FERNANDO ARA ISMAEL;HERRANDO PE脩A FERNANDO. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTIJORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3946 , F 49, S 8, H Z54231, I/A 12 (18.02.16).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3946 , F 49, S 8, H Z 54231, I/A 13 (18.02.16).

Nombramientos. Apoderado: MILLAN ARNUELOS JULIO. Datos registrales. T 3946 , F 49, S 8, H Z 54231, I/A 14 (18.02.16).

Nombramientos. Apoderado: QUILEZ SAZ RAFAEL. Datos registrales. T 3946 , F 50, S 8, H Z 54231, I/A 15 (18.02.16).

Nombramientos. Apo.D.Gral.: RIVERA BELLOC ALFONSO. Datos registrales. T 3946 , F 51, S 8, H Z 54231, I/A 16 (18.02.16).

Nombramientos. Apo.D.Gral.: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE. Datos registrales. T 3946 , F 52, S 8, H Z 54231, I/A 17(18.02.16).

Nombramientos. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4158 , F 25, S 8, H Z 54231, I/A 18 (18.02.16).

28 de Enero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.670.000,00 Euros. Datos registrales. T 3946 , F 47, S8, H Z 54231, I/A 11 (20.01.16).

07 de Octubre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGROALIMENTARIA DE CASPE SA. FRUTOS DEL EBRO SA. Datos registrales.T 3946 , F 47, S 8, H Z 54231, I/A 10 (30.09.15).

15 de Septiembre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGOSANZ GREGORIO-JUAN. Con.Delegado: LUENGO SANZ GREGORIO-JUAN. Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO-JUAN.Nombramientos. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Secretario: LUENGO EGIDO JAVIER. Con.Delegado:LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 3946 , F 47, S 8, H Z 54231, I/A 8 ( 7.09.15).

Modificaciones estatutarias. "Art铆culo 13潞.- La Sociedad ser谩 regida y administrada por un consejo de administraci贸n. El Consejo deAdministraci贸n estar谩 formado por un n煤mero de miembros determinado por la Junta General de entre un m铆nimo de tres y un m谩ximode doce. Los miembros del consejo ser谩n nombrados por la Junta. Datos registrales. T 3946 , F 47, S 8, H Z 54231, I/A 9 ( 7.09.15).

25 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL ORDEN OLASAGASTI JORGE;RIVERA BELLOCH ALFONSO. Datos registrales. T 3946 , F46, S 8, H Z 54231, I/A 6 (17.02.14).

Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3946 , F 47, S 8, H Z 54231, I/A 7 (17.02.14).

14 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: HERRANDO PE脩A FERNANDO. Datos registrales. T 3946 , F 46, S 8, H Z 54231, I/A 5 ( 6.02.14).

22 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Con.Delegado: LIZARRAGA CORTES FERNANDO.Nombramientos. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDO JAVIER. Datos registrales. T 3946 , F 46, S8, H Z 54231, I/A 4 (14.01.14).

12 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3946 , F 45, S 8, H Z54231, I/A 3 ( 2.12.13).

08 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: FERNANDO ARA ISMAEL. Datos registrales. T 3946 , F 45, S 8, H Z 54231, I/A 2 (31.01.13).

08 de Enero de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.01.13. Objeto social: La adquisici贸n de fincas agr铆colas, su transformaci贸n y mejora,concentraci贸n y desconcentraci贸n de ellas, producci贸n, comercializaci贸n, industrializaci贸n y exportaci贸n de toda clase de productos dela agricultura y ganader铆a, y de maquinaria o elementos para ellas. Domicilio: AVDA CESAR AUGUSTO 3 7潞 (ZARAGOZA). Capital:19.670.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL.Consejero: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Con.Delegado: LIZARRAGA CORTES FERNANDO. Consejero: LUENGO SANZGREGORIO-JUAN. Con.Delegado: LUENGO SANZ GREGORIO-JUAN. Secretario: LUENGO SANZ GREGORIO-JUAN. Datosregistrales. T 3946 , F 44, S 8, H Z 54231, I/A 1 (28.12.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n