Actos BORME de Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl
04 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: BARCELO MAZARRON LUIS;VALCANERAS DE RODA I脩IGO;MORENO AYMI ENRIQUE;SERRANOBARRIO FERNANDO. Apo.Manc.: NAUDE HURTADO SUSANA;SERRANO BARRIO FERNANDO. Apo.Sol.: DUO DELGADO JOSELUIS;DOMINGUEZ SANTA MARIA FABIAN;ORTEGA COBO LUIS ANTONIO;CANTERO FRESNEDA CRISTINA;VICARIO LA CALLEALFONSO MARIA. Datos registrales. T 28451 , F 12, S 8, H M 292924, I/A 30 (28.03.23).
19 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE;CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE.Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Vicesecret.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Revocaciones. Apo.Man.Soli:MESNARD SEBASTIEN. Nombramientos. Consejero: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT.Presidente: GUILLOT LAURENT. VsecrNoConsj: VICARIO LA CALLE ALFONSO MARIA. Apo.Sol.: GUILLOT LAURENT;GIACCARDOBERENGERE;LEMAIRE LAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION;AZNAR AZNAR MANUEL;GUILLOTLAURENT;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION.Apo.Manc.: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRELAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A 29(12.01.23).
06 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Nombramientos. Consejero: CHARRIERPHILIPPE JEAN PIERRE. Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A28 (30.05.22).
23 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A 27 (16.11.21).
12 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8,H M 292924, I/A 26 ( 4.11.21).
25 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8,H M 292924, I/A 25 (18.06.21).
08 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE PIERRE;ORPEA SA. Representan: MESNARD SEBASTIEN.Nombramientos. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8, H M292924, I/A 24 ( 1.03.21).
24 de Enero de 2020Cambio de domicilio social. PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 46, 7陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 28451 ,F 8, S 8, H M 292924, I/A 23 (17.01.20).
16 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 8, S 8, H M 292924, I/A 22 (8.11.18).
23 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIAN JEAN CLAUDE. Presidente: MARIAN JEAN CLAUDE. Nombramientos. Consejero: LEMASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Datos registrales. T 28451 , F 7, S 8, H M 292924, I/A 21 (16.05.17).
20 de Abril de 2017Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 23 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 28451 , F 7, S 8, H M 292924, I/A 20(11.04.17).
03 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE;MESNARD SEBASTIEN. Datos registrales. T 28451 , F 6, S 8, H M292924, I/A 19 (23.02.17).
30 de Octubre de 2015Nombramientos. Vicesecret.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 28451 , F 6, S 8, H M 292924, I/A 18 (23.10.15).
01 de Octubre de 2015Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M292924, I/A 17 (24.09.15).
23 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RAMOS TRIVI脩O OSCAR JUAN. Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M 292924, I/A 16(16.02.15).
23 de Mayo de 2012Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO, LA SOCIEDAD DENOMINADA "ORPEA IBERICA SA".Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M 292924, I/A 15 (10.05.12).
21 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROYECTOS AUMAY SL. Representan: ALVAREZ CORRAL SERGIO. Nombramientos.Representan: MESNARD SEBASTIEN. SecreNoConsj: SOLCHAGA LOPEZ DE SILANES FRANCISCO. Consejero: MARIAN JEANCLAUDE. Presidente: MARIAN JEAN CLAUDE. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE PIERRE;ORPEA SA. VsecrNoConsj: RAMOSTRIVI脩O OSCAR JUAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 12 ( 8.05.12).
Cambio de domicilio social. C/ MONTE ESQUINZA 30 7潞 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 28451 , F 3, S 8, H M292924, I/A 13 ( 8.05.12).
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ ALVAREZ AURELIO;APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL;LATASA MICHEOAMPARO;PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER;PEREZ-OCHOA REAL MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR AZNARMANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 28451 , F 3, S 8, H M292924, I/A 14 ( 8.05.12).
02 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 11 (22.02.12).
22 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: CARLOS MIGUELEZ & CO SC. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 10 (12.09.11).
21 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA;PROYECTOS AUMAY SL;RENDAURSL;SENAVAR URBANIZACIONES SL. Presidente: SENAVAR URBANIZACIONES SL. Secretario: PROYECTOS AUMAY SL.Cons.Del.Man: SENAVAR URBANIZACIONES SL;GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA. Representan: LATASAMICHEO AMPARO;APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL;ALVAREZ CORRAL SERGIO;ALVAREZ CORRAL EDUARDOAURELIO. Nombramientos. Adm. Unico: PROYECTOS AUMAY SL. Representan: ALVAREZ CORRAL SERGIO. Reducci贸n decapital. Importe reducci贸n: 1.039.220,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.039.220,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 28451 , F 1, S 8, H M 292924, I/A 9( 4.02.11).
10 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL. Presidente: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL.Consejero: LATASA MICHEO AMPARO. Cons.Del.Man: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL. Consejero: PIZARRO VINDELJOSE JAVIER. Secretario: PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER. Cons.Del.Man: PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER. Nombramientos.