Buscador CIF Logo

Actos BORME Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl

Actos BORME Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl - B83179788

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl con CIF B83179788

馃敊 Perfil de Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Explotacion De Residencia Del Real Sitio De San Fernando Sl

04 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BARCELO MAZARRON LUIS;VALCANERAS DE RODA I脩IGO;MORENO AYMI ENRIQUE;SERRANOBARRIO FERNANDO. Apo.Manc.: NAUDE HURTADO SUSANA;SERRANO BARRIO FERNANDO. Apo.Sol.: DUO DELGADO JOSELUIS;DOMINGUEZ SANTA MARIA FABIAN;ORTEGA COBO LUIS ANTONIO;CANTERO FRESNEDA CRISTINA;VICARIO LA CALLEALFONSO MARIA. Datos registrales. T 28451 , F 12, S 8, H M 292924, I/A 30 (28.03.23).

19 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE;CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE.Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Vicesecret.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Revocaciones. Apo.Man.Soli:MESNARD SEBASTIEN. Nombramientos. Consejero: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT.Presidente: GUILLOT LAURENT. VsecrNoConsj: VICARIO LA CALLE ALFONSO MARIA. Apo.Sol.: GUILLOT LAURENT;GIACCARDOBERENGERE;LEMAIRE LAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION;AZNAR AZNAR MANUEL;GUILLOTLAURENT;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION.Apo.Manc.: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRELAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A 29(12.01.23).

06 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Nombramientos. Consejero: CHARRIERPHILIPPE JEAN PIERRE. Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A28 (30.05.22).

23 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 10, S 8, H M 292924, I/A 27 (16.11.21).

12 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8,H M 292924, I/A 26 ( 4.11.21).

25 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8,H M 292924, I/A 25 (18.06.21).

08 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE PIERRE;ORPEA SA. Representan: MESNARD SEBASTIEN.Nombramientos. Consejero: MESNARD SEBASTIAN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE. Datos registrales. T 28451 , F 9, S 8, H M292924, I/A 24 ( 1.03.21).

24 de Enero de 2020
Cambio de domicilio social. PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 46, 7陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 28451 ,F 8, S 8, H M 292924, I/A 23 (17.01.20).

16 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 8, S 8, H M 292924, I/A 22 (8.11.18).

23 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIAN JEAN CLAUDE. Presidente: MARIAN JEAN CLAUDE. Nombramientos. Consejero: LEMASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Datos registrales. T 28451 , F 7, S 8, H M 292924, I/A 21 (16.05.17).

20 de Abril de 2017
Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 23 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 28451 , F 7, S 8, H M 292924, I/A 20(11.04.17).

03 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE;MESNARD SEBASTIEN. Datos registrales. T 28451 , F 6, S 8, H M292924, I/A 19 (23.02.17).

30 de Octubre de 2015
Nombramientos. Vicesecret.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 28451 , F 6, S 8, H M 292924, I/A 18 (23.10.15).

01 de Octubre de 2015
Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M292924, I/A 17 (24.09.15).

23 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RAMOS TRIVI脩O OSCAR JUAN. Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M 292924, I/A 16(16.02.15).

23 de Mayo de 2012
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO, LA SOCIEDAD DENOMINADA "ORPEA IBERICA SA".Datos registrales. T 28451 , F 5, S 8, H M 292924, I/A 15 (10.05.12).

21 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROYECTOS AUMAY SL. Representan: ALVAREZ CORRAL SERGIO. Nombramientos.Representan: MESNARD SEBASTIEN. SecreNoConsj: SOLCHAGA LOPEZ DE SILANES FRANCISCO. Consejero: MARIAN JEANCLAUDE. Presidente: MARIAN JEAN CLAUDE. Consejero: BRDENK JEAN CLAUDE PIERRE;ORPEA SA. VsecrNoConsj: RAMOSTRIVI脩O OSCAR JUAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 12 ( 8.05.12).

Cambio de domicilio social. C/ MONTE ESQUINZA 30 7潞 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 28451 , F 3, S 8, H M292924, I/A 13 ( 8.05.12).

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ ALVAREZ AURELIO;APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL;LATASA MICHEOAMPARO;PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER;PEREZ-OCHOA REAL MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR AZNARMANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 28451 , F 3, S 8, H M292924, I/A 14 ( 8.05.12).

02 de Marzo de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 11 (22.02.12).

22 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Auditor: CARLOS MIGUELEZ & CO SC. Datos registrales. T 28451 , F 2, S 8, H M 292924, I/A 10 (12.09.11).

21 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA;PROYECTOS AUMAY SL;RENDAURSL;SENAVAR URBANIZACIONES SL. Presidente: SENAVAR URBANIZACIONES SL. Secretario: PROYECTOS AUMAY SL.Cons.Del.Man: SENAVAR URBANIZACIONES SL;GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES SA. Representan: LATASAMICHEO AMPARO;APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL;ALVAREZ CORRAL SERGIO;ALVAREZ CORRAL EDUARDOAURELIO. Nombramientos. Adm. Unico: PROYECTOS AUMAY SL. Representan: ALVAREZ CORRAL SERGIO. Reducci贸n decapital. Importe reducci贸n: 1.039.220,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.039.220,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 28451 , F 1, S 8, H M 292924, I/A 9( 4.02.11).

10 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL. Presidente: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL.Consejero: LATASA MICHEO AMPARO. Cons.Del.Man: APEZTEGUIA LANASPA JOSE GABRIEL. Consejero: PIZARRO VINDELJOSE JAVIER. Secretario: PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER. Cons.Del.Man: PIZARRO VINDEL JOSE JAVIER. Nombramientos.

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n