Buscador CIF Logo

Actos BORME Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima

Actos BORME Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima - A28218832

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Ciudad Real para Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima con CIF A28218832

馃敊 Perfil de Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Ciudad Real

Actos BORME de Explotaciones Puerto Vallehermoso Sociedad Anonima

29 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: ARGUDO GARCIA MOISES;ARGUDO GARCIA JOSE MIGUEL. Apo.Sol.: FUENTES GARCIAVICTOR;ARGUDO GARCIA MERCEDES. Apoderado: JIMENO JAIME PEDRO;LARA ALHAMBRA JUAN;LUNA DEL FRESNORAMON;ARGUDO GARCIA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 725 , F 56, S 8, H CR 2156, I/A 53 (21.12.23).

13 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PICASSO CLARKE ANA MARIA;SERRANO LAREZ ARTURO;LEIVA FLORES JUAN FELIPE.Datos registrales. T 725 , F 53, S 8, H CR 2156, I/A 52 ( 4.12.23).

22 de Noviembre de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES AGRICOLAS VALLEHERMOSO SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:ARGUDO GARCIA MOISES;ARGUDO GARCIA MERCEDES;QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA. Secretario: ARGUDOGARCIA MERCEDES. Presidente: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA. Nombramientos. Adm. Unico: MULDER FORTPAUL FREDERIC. Modificaciones estatutarias. Modificar el art铆culo 9 de los estatutos en cuanto a los Organos de la sociedad. .Modificado el ARTICULO 14 de los estatutos en cuanto al 贸rgano de administraci贸n.. Modificado el art铆culo 15 de los estatutos encuento a las actas.. Se modifica el ARTICULO 16 de los estatutos, en cuanto al 贸rgano de administraci贸n.. Se modifica el ARTICULO21 de los estatutos, en cuanto al acta del consejo.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 642 , F 211, S 8, H CR 2156, I/A 51 (15.11.23).

24 de Octubre de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO el ARTICULO 5 por la CONVERSION de las ACCIONES al PORTADOR en ACCIONESNOMINATIVAS. Otros conceptos: CONVERTIR las ACCIONES al PORTADOR de la SOCIEDAD en ACCIONES NOMINATIVAS yMODIFICAR el ARTICULO 5 de los ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 642 , F 211, S 8, H CR 2156, I/A 50 (17.10.22).

10 de Agosto de 2022
Reelecciones. Consejero: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA;ARGUDO GARCIA MERCEDES;ARGUDO GARCIAMOISES. Presidente: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA. Secretario: ARGUDO GARCIA MERCEDES. Datosregistrales. T 642 , F 210, S 8, H CR 2156, I/A 49 ( 3.08.22).

19 de Octubre de 2021
Nombramientos. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 642 , F 225, S 8, H CR2156, I/A 48 (13.10.21).

18 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: JIMENO JAIME PEDRO. Datos registrales. T 542 , F 225, S 8, H CR 2156, I/A 47 ( 9.08.21).

31 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 542 , F 225, S 8, H CR2156, I/A 46 (18.01.19).

17 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ARGUDO GARCIA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 542 , F 203, S 8, H CR 2156, I/A 45 (6.08.18).

13 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: LUNA DEL FRESNO RAMON. Datos registrales. T 542 , F 203, S 8, H CR 2156, I/A 43 ( 6.08.18).

Nombramientos. Apoderado: LARA ALHAMBRA JUAN. Datos registrales. T 542 , F 203, S 8, H CR 2156, I/A 44 ( 6.08.18).

22 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 542 , F 202, S 8, H CR2156, I/A 42 (28.08.17).

18 de Agosto de 2017
Reelecciones. Consejero: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA;ARGUDO GARCIA MERCEDES;ARGUDO GARCIAMOISES. Presidente: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA. Secretario: ARGUDO GARCIA MERCEDES. Datosregistrales. T 542 , F 201, S 8, H CR 2156, I/A 41 (28.07.17).

16 de Febrero de 2017
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 542 , F 201, S 8, H CR2156, I/A 40 ( 8.02.17).

28 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 542 , F 201, S 8, H CR2156, I/A 39 (15.07.16).

04 de Julio de 2016
Revocaciones. Apoderado: JUSTINIANO MARQUEZ MARIA SALUD. Datos registrales. T 542 , F 201, S 8, H CR 2156, I/A 38(27.06.16).

11 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 542 , F 201, S 8, H CR2156, I/A 37 (31.07.15).

12 de Septiembre de 2014
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GOMEZ TARRAGONA RAMON;DELOITTE & TOUCHE ESPA脩A SOCIEDADLIMITADA EN LA A. Aud.Supl.: CACERES GALINDO FERMIN FRANCISCO. Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZODURBAN AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 542 , F 200, S 8, H CR 2156, I/A 36 (11.08.14).

04 de Marzo de 2013
Reelecciones. Consejero: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA;ARGUDO GARCIA MERCEDES;ARGUDO GARCIAMOISES. Presidente: QUESERIA MANCHEGA SOCIEDAD ANONIMA. Secretario: ARGUDO GARCIA MERCEDES. Datosregistrales. T 542 , F 200, S 8, H CR 2156, I/A 34 (11.02.13).

Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO DURBAN AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 542 , F 200, S 8, HCR 2156, I/A 35 (11.02.13).

23 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: SEVILLANO CARAZO DURBAN AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 426 , F 59, S 8, HCR 2156, I/A 33 ( 4.02.12).

07 de Enero de 2009
Nombramientos. Auditor: SEVILLANO CARAZO DURBAN AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 426 , F 59, S 8,H CR 2156, I/A 32 (10.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n