Actos BORME de Expociencia Sl
14 de Noviembre de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 659/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 19/10/2017. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: OLGA MARTINALONSO. Resoluciones: SE ACUERDA LA CONCLUSION Y EL CESE DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL, LA EXTINCION DE.LASOCIEDAD Y LA CANCELACION DE INSCRIPCIONES.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 659/2015. FIRME: Si,Fecha de resoluci贸n 19/10/2017. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE MADRID. Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 659/2015. Fecha deresoluci贸n 17/11/2015. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID.Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Administrador Concursal. Fecha 19/10/2017, NIF/CIF 03064415X. LATORRE ATANCE ALEJANDRO.Extinci贸n. Datos registrales. T 17417 , F 182, S 8, H M 90920, I/A 42 ( 3.11.17).
13 de Enero de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 659/2015. Fecha de resoluci贸n 17/11/2015. Nombramiento de administradores.
11 de Diciembre de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 659/2015. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/11/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Resoluciones: DECLARACION DE CONCURSOVOLUNTARIO CONSERVANDO EL DEUDOR LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SUPATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDAS A LA INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL. Datos registrales. T17417 , F 180, S 8, H M 90920, I/A A ( 2.12.15).
18 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ NAVARRO NAVARRETE JAVIER. Secretario: SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL.Consejero: RODRIGUEZ MU脩OZ JULIO ALBERTO;GOMEZ NAVARRO NAVARRETE JAVIER;SERRANO MARTINEZ ESTELLEZANGEL;CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: MOLINA MOLINA JESUS RAFAEL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 17417 , F179, S 8, H M 90920, I/A 40 (10.09.15).
09 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GIMENEZ CAYUELA ANTONIO. Consejero: GIMENEZ CAYUELA ANTONIO. Revocaciones.Apoderado: ALBERO SILLA VICENTE. Nombramientos. Apoderado: FARIAS MARCOS BEATRIZ. Datos registrales. T 17417 , F176, S 8, H M 90920, I/A 39 ( 2.06.14).
21 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: RUA RODRIGUEZ ANGEL JOEL. Nombramientos. Apoderado: ALBERO SILLA VICENTE. Datosregistrales. T 17417 , F 173, S 8, H M 90920, I/A 37 (13.11.13).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ CALMAESTRA JUAN LUIS. Datos registrales. T 17417 , F 176, S 8, H M 90920, I/A 38(13.11.13).
13 de Agosto de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 74.623.700 Ptas. Resultante Suscrito: 250.000 Ptas. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:1.502,53 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Cambio de domicilio social. C/ RIOS ROSAS 36 6& (MADRID). Datosregistrales. T 17417 , F 172, S 8, H M 90920, I/A 36 (31.07.12).
16 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE TORRES QUINTANA MANUEL. Datos registrales. T 17417 , F 172, S 8, H M 90920, I/A 35 (3.07.12).
08 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ OTERO PEREZ RUTILIO. Datos registrales. T 17417 , F 170, S 8, H M 90920, I/A 34(27.05.11).
16 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: PICO MANVILLE MARTA GUILLERMINA;DE TORRES QUINTANA MANUEL;PICO MANVILLE MARTAGUILLERMINA;FARIAS MARCOS BEATRIZ;DE TORRES QUINTANA MANUEL;BAEZ FAUNDEZ EDUARDO;NAVARRO OTEIZAAMAYA;MARTINEZ-OTERO PEREZ RUTILIO;NAVARRO OTEIZA AMAYA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ-OTEROPEREZ RUTILIO;FARIAS MARCOS BEATRIZ;DE TORRES QUINTANA MANUEL. Datos registrales. T 17417 , F 168, S 8, H M90920, I/A 33 ( 4.05.11).
06 de Mayo de 2011Ampliacion del objeto social. Dise帽o, producci贸n y ejecuci贸n de espect谩culos de todo tipo tales como multimedia, Shunt Shows,esc茅nicos, animaci贸n de calle. Todo tipo de actividadrelacionada con la producci贸n y ejecuci贸n de escenogr谩fia y tematizaci贸n enparques tem谩ticos, parques de atracciones, auditorios, centros culturales,. Datos registrales. T 17417 , F 167, S 8, H M 90920, I/A 32(25.04.11).
24 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CALVO I脩ARRA JESUS MARIA. Con.Delegado: CALVO I脩ARRA JESUS MARIA. Datos registrales.T 17417 , F 166, S 8, H M 90920, I/A 30 (15.02.11).
Nombramientos. Apoderado: RUA RODRIGUEZ ANGEL JOEL. Datos registrales. T 17417 , F 166, S 8, H M 90920, I/A 31(15.02.11).
25 de Enero de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. LA REALIZACION DEMATERIAL AUDIOVISUAL, INCLUYENDO TRABAJOS DE PRODUCCION DE PELICULAS, VEDEOS, DISCOS, CASETES, FOTOS,DIAPOSITIVAS Y OTROS PRODUCTOS AUDIOVISUALES.- Datos registrales. T 17417 , F 165, S 8, H M 90920, I/A 29 (14.01.11).
03 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: CIPRIAN BLANCO JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ-OTERO PEREZRUTILIO;NAVARRO OTEIZA AMAYA. Datos registrales. T 17417 , F 118, S 8, H M 90920, I/A 28 (22.01.10).
17 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: CIPRIAN BLANCO JOSELUIS;NAVARRO OTEIZA AMAYA. Datos registrales. T 17417 , F 117, S 8, H M 90920, I/A 27 ( 4.11.09).
25 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: ROCA MONTES RICARDO JOSE;ROCA MONTES RICARDO JOSE. Nombramientos. Apoderado:REDONDO CASTRO FRANCISCO-IGNACIO. Datos registrales. T 17417 , F 115, S 8, H M 90920, I/A 26 (16.02.09).