Actos BORME de Exposuiza Sociedad Limitada
09 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5227 , F 58, S 8, H SE 52077,I/A 29 ( 2.06.22).
Revocaciones. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5227 , F 58, S 8, H SE 52077, I/A 30 ( 2.06.22).
Revocaciones. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5227 , F 59, S 8, H SE 52077, I/A 31 ( 2.06.22).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5227 , F 59, S 8, H SE 52077,I/A 32 ( 2.06.22).
Revocaciones. Apoderado: MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU;ABASOLO GALDOS ANA MARIA;MANZANARESABASOLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5227 , F 59, S 8, H SE 52077, I/A 33 ( 2.06.22).
29 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. C/ BETIS 29 2潞 -IZQUIERDA - CP 41010 (SEVILLA). Datos registrales. T 5227 , F 58, S 8, H SE 52077, I/A 28 (21.12.21).
30 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5227 , F 57, S 8, H SE 52077, I/A 27(21.12.15).
06 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. 47. Caracter del cargo de Administrador.-Retribuci贸n. Datos registrales. T 5227 , F 57, S 8, H SE52077, I/A 26 (27.01.15).
19 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ABASOLO GALDOS ANA MARIA;MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU;MANZANARESABASOLO JOSE LUIS. Presidente: ABASOLO GALDOS ANA MARIA. Secretario: MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU.Consejero: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: BEATRIZ BEASCOECHEA ABASOLO.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 5227 , F 56, S 8, H SE 52077, I/A 25 ( 6.08.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5227 , F 56, S 8, H SE 52077, I/A 24(25.02.14).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO. Datos registrales. T 5227 , F 55, S 8, H SE 52077, I/A 23(21.02.14).
01 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Datos registrales. T 5227 , F 55, S 8, H SE 52077, I/A 22 (23.07.13).
13 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 58.960,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.892.240,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: SE SUPRIMEEL ARTICULO 72潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SOBRE CONVENIO ARBITRAL. Datos registrales. T 5138 , F 39, S 8, H SE52077, I/A 21 ( 5.03.13).
04 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5138 , F 36, S 8, H SE 52077,I/A 20 (23.01.13).
08 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5138 , F 33, S 8, H SE 52077,I/A 19 (25.09.12).
21 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FINARPISA SA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL. Datosregistrales. T 5138 , F 33, S 8, H SE 52077, I/A 18 ( 9.11.11).