Actos BORME de Exyprom Sl
30 de Noviembre de 2023Otros conceptos: Modificaci贸n del r茅gimen de actuaci贸n de los Consejeros Delegados. Datos registrales. T 6989 , F 210, S 8, H M113660, I/A 12 (23.11.23).
22 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ROQUE MARIA JOSE. Datos registrales. T 6989 , F 210, S 8, H M 113660, I/A 11(15.07.20).
17 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO ORTEGA MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: ALONSO ORTEGA MARIA DEL CARMEN.Presidente: PORQUERAS MESTRES ALBERTO FRANCISCO. Consejero: PORQUERAS MESTRES ALBERTO FRANCISCO.Nombramientos. Presidente: PORQUERAS ALONSO FRANCISCO LUIS. Vicepresid.: PORQUERAS ALONSO RAMON MIGUEL.Reelecciones. Secretario: PORQUERAS ALONSO GABRIEL ALBERTO. Datos registrales. T 6989 , F 210, S 8, H M 113660, I/A 10( 5.07.12).
25 de Abril de 2011Cambio de domicilio social. C/ TOMAS REDONDO NUMERO 2 (MADRID). Datos registrales. T 6989 , F 210, S 8, H M 113660,I/A 9 ( 7.04.11).
18 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PORQUERAS MESTRES ALBERTO FRANCISCO;ALONSO ORTEGA MARIA DEL CARMEN.Revocaciones. Apoderado: PORQUERAS ALONSO GABRIEL ALBERTO;PORQUERAS ALONSO FRANCISCO LUIS;PORQUERASALONSO RAMON MIGUEL;PORQUERAS ALONSO GABRIEL ALBERTO;PORQUERAS ALONSO FRANCISCO LUIS.Nombramientos. Consejero: PORQUERAS ALONSO RAMON MIGUEL. Vicepresid.: ALONSO ORTEGA MARIA DEL CARMEN.Co.De.Ma.So: PORQUERAS ALONSO GABRIEL ALBERTO;PORQUERAS ALONSO FRANCISCO LUIS;PORQUERAS ALONSORAMON MIGUEL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 8潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 6989 , F 137, S 8, H M 113660, I/A 8 ( 6.04.11).