Buscador CIF Logo

Actos BORME F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl

Actos BORME F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl - B61698247

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl con CIF B61698247

馃敊 Perfil de F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de F 10 Factoria De Serveis Electrics Sl

14 de Mayo de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 7: MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES. Cambio de objeto social.AMPLIAR EN: "SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIA TECNICA EN MATERIA ELECTRICA Y ENERGIAS RENOVABLES.INTERMEDIACION COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOSENERGETICOS. ACTIVIDAD FOTOVOLTAICA, EXPLOTACIONDE PLANTAS DE ENERGIA...". Datos registrales. T 42002 , F 56, S 8, H B 182425, I/A 42 ( 2.05.13).

28 de Enero de 2013
Nombramientos. APODERADO: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 42002 , F 55, S 8, H B 182425, I/A 41(18.01.13).

28 de Febrero de 2012
Revocaciones. APODERADO: MORALES BERGO脩O JORDI;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 42002 , F 54, S 8, H B 182425, I/A 40 (16.02.12).

23 de Enero de 2012
Revocaciones. APODERADO: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 42002 , F 51, S 8, H B 182425, I/A 37 (10.01.12).

Nombramientos. APODERADO: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 42002 , F 51, S 8, H B 182425, I/A 38(10.01.12).

Nombramientos. APODERADO: GOMEZ PRAT SERGIO. Datos registrales. T 42002 , F 53, S 8, H B 182425, I/A 39 (10.01.12).

11 de Abril de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: VINCENT ROVERATO. PRESIDENTE: VINCENT ROVERATO. Nombramientos. CONSEJERO:ARNAUD JEAN ANDRE PERETMERE. PRESIDENTE: ARNAUD JEAN ANDRE PERETMERE. Datos registrales. T 42002 , F 51, S8, H B 182425, I/A 36 (30.03.11).

28 de Julio de 2010
Revocaciones. APODERADO: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;MORALES BERGO脩O JORDI;LASHERAS LOPEZ MARIADOLORES. Datos registrales. T 40494 , F 140, S 8, H B 182425, I/A 35 (19.07.10).

16 de Julio de 2010
Revocaciones. PRESIDENTE: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: VINCENT ROVERATO.PRESIDENTE: VINCENT ROVERATO. Datos registrales. T 40494 , F 140, S 8, H B 182425, I/A 34 ( 6.07.10).

18 de Mayo de 2010
Nombramientos. APODERADO: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE. Datos registrales. T 40494 , F 138, S 8, H B 182425, I/A 32 (6.05.10).

Nombramientos. APODERADO: MORALES BERGO脩O JORDI. Datos registrales. T 40494 , F 139, S 8, H B 182425, I/A 33 (6.05.10).

01 de Diciembre de 2009
Revocaciones. APODERADO: RODRIGUEZ DEL PALACIO MIGUEL ANGEL;LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES. Datosregistrales. T 40494 , F 137, S 8, H B 182425, I/A 31 (19.11.09).

30 de Octubre de 2009
Cambio de domicilio social. CR STA.CREU DE CALAFELL,47-49 PI.FONALLAR-SUR (SANT BOI DE LLOBREGAT). Datosregistrales. T 40494 , F 137, S 8, H B 182425, I/A 30 (19.10.09).

26 de Junio de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: JEAN MARIE FRANCOIS SERRALTA. PRESIDENTE: JEAN MARIE FRANCOIS SERRALTA.CONSEJERO: FRANCOIS MICHEL MARIE LECHARNY. SECRETARIO: FRANCOIS MICHEL MARIE LECHARNY. CONSEJERO:MAX ANDRE JOSEPH ROCHE. Nombramientos. CONSEJERO: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. SECRETARIO: LOPEZ GONZALEZPEDRO. CONSEJERO: LASHERAS LOPEZ MARIA DOLORES. PRESIDENTE: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 40494 , F 137, S 8, H B 182425, I/A 29 (16.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n