Actos BORME de Fabricacion Componentes Motocicletas Sa
10 de Abril de 2023Revocaciones. APOD.MANCOMU: CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO;ALCARAZ APARICIO ALBERT. Datos registrales. T46268 , F 126, S 8, H B 79221, I/A 55 (29.03.23).
06 de Septiembre de 2022Revocaciones. CONSEJERO: ERANS ALBERT EMILIO. CONS. DELEG.: ERANS ALBERT EMILIO. PRESIDENTE: ERANSALBERT EMILIO. Nombramientos. CONSEJERO: ERANS ALBERT EMILIO. PRESIDENTE: ERANS ALBERT EMILIO. Datosregistrales. T 46268 , F 126, S 8, H B 79221, I/A 53 (30.08.22).
28 de Julio de 2021Nombramientos. CONS.DEL.SOL: LOPEZ GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 46268 , F 126, S 8, H B 79221, I/A 52(20.07.21).
17 de Octubre de 2019Nombramientos. APOD.MANCOMU: CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO;ALCARAZ APARICIO ALBERT. Datos registrales. T46268 , F 124, S 8, H B 79221, I/A 51 (11.10.19).
15 de Octubre de 2019Revocaciones. CONSEJERO: JOFRE FRADERA JOAN;MALAPEIRA GAS JORDI. PRESIDENTE: MALAPEIRA GAS JORDI. CONS.DELEG.: MALAPEIRA GAS JORDI. Nombramientos. CONSEJERO: LOPEZ GONZALEZ JOSE;VI脩ALS GA脩AN ANTONIA.PRESIDENTE: ERANS ALBERT EMILIO. SECR.NO CONS: MUES LERONES ISRAEL. Datos registrales. T 46268 , F 124, S 8, H B79221, I/A 50 ( 4.10.19).
27 de Febrero de 2019Revocaciones. CONSEJERO: VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 46268 , F 124, S 8, H B 79221, I/A 49(19.02.19).
16 de Abril de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 46268 , F 122, S 8, H B 79221,I/A 47 ( 6.04.18).
Nombramientos. APODERAD.SOL: DOMINGUEZ CANO ALFONSO. Datos registrales. T 46268 , F 123, S 8, H B 79221, I/A 48 (6.04.18).
05 de Abril de 2018Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: BESSERUP SL. Datos registrales. T 46268 , F 122, S 8, H B79221, I/A 46 (27.03.18).
08 de Enero de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: CERRATO SANTIAGO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 40478 , F 110, S 8, H B 79221,I/A 45 (28.12.17).
11 de Octubre de 2017Revocaciones. CONSEJERO: TERRADAS RIULAS ISIDORO. PRESIDENTE: TERRADAS RIULAS ISIDORO. CONSEJERO: MILAPLANS JORGE;SORIANO ALVAREZ MANUEL. CONS. DELEG.: TERRADAS RIULAS ISIDORO. Nombramientos. CONSEJERO:ERANS ALBERT EMILIO. PRESIDENTE: ERANS ALBERT EMILIO. CONS. DELEG.: ERANS ALBERT EMILIO. CONSEJERO: JOFREFRADERA JOAN;VICENTE MARTINEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 40478 , F 110, S 8, H B 79221, I/A 43 ( 4.10.17).
Revocaciones. PRESIDENTE: ERANS ALBERT EMILIO. Nombramientos. CONSEJERO: MALAPEIRA GAS JORDI.PRESIDENTE: MALAPEIRA GAS JORDI. CONS. DELEG.: MALAPEIRA GAS JORDI. Datos registrales. T 40478 , F 110, S 8, H B79221, I/A 44 ( 4.10.17).
04 de Julio de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 999.999,99 Euros. Desembolsado: 999.999,99 Euros. Resultante Suscrito: 1.061.849,22 Euros.Resultante Desembolsado: 1.061.849,22 Euros. Datos registrales. T 40478 , F 109, S 8, H B 79221, I/A 42 (23.06.16).
27 de Junio de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS SL. Datos registrales. T 40478 , F 109, S 8, H B 79221,I/A 41 (20.06.16).
10 de Enero de 2014Nombramientos. CONS. DELEG.: TERRADAS RIULAS ISIDORO. Datos registrales. T 40478 , F 109, S 8, H B 79221, I/A 40 (2.01.14).
12 de Febrero de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: SORIANO ALVAREZ MANUEL;LEMUS TOMAS FERRAN.VICEPRESIDEN: LEMUS TOMAS FERRAN. Datos registrales. T 36601 , F 139, S 8, H B 79221, I/A 25 N (28.01.13).
05 de Febrero de 2013Revocaciones. SECR.NO CONS: RE脩AGA RUBIN CARMEN. CONSEJERO: MILA PLANS JORDI;TERRADAS RIULAS ISIDORO.PRESIDENTE: TERRADAS RIULAS ISIDORO. CONS. DELEG.: TERRADAS RIULAS ISIDORO. CONSEJERO: HIGHGROWTHPARTNERS SGECR SA. REPR.143 RRM: POCH GAUDIER EULALIA. Nombramientos. CONSEJERO: TERRADAS RIULASISIDORO. PRESIDENTE: TERRADAS RIULAS ISIDORO. CONSEJERO: MILA PLANS JORGE;SORIANO ALVAREZ MANUEL.SECR.NO CONS: MUES LERONES ISRAEL. Datos registrales. T 40478 , F 108, S 8, H B 79221, I/A 39 (28.01.13).
08 de Agosto de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.752.394,85 Euros. Resultante Suscrito: 61.849,23 Euros. Datos registrales. T 40478 , F108, S 8, H B 79221, I/A 38 (27.07.11).
20 de Abril de 2011Revocaciones. CONSEJERO: POCH GAUDIER EULALIA. Nombramientos. CONSEJERO: HIGHGROWTH PARTNERS SGECRSA. REPR.143 RRM: POCH GAUDIER EULALIA. Datos registrales. T 40478 , F 107, S 8, H B 79221, I/A 37 ( 7.04.11).
28 de Octubre de 2010Revocaciones. AUDT.CTS.CON: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 40478 , F 107, S 8, H B 79221, I/A36 (15.10.10).
28 de Julio de 2010Nombramientos. CONSEJERO: MILA PLANS JORDI;TERRADAS RIULAS ISIDORO. CONS. DELEG.: TERRADAS RIULASISIDORO. Datos registrales. T 40478 , F 107, S 8, H B 79221, I/A 35 (19.07.10).
31 de Marzo de 2010Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: BESSERUP SL. Datos registrales. T 40478 , F 103, S 8, H B 79221, I/A32 (18.03.10).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 247.396,92 Euros. Resultante Suscrito: 1.814.244,08 Euros. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: BESSERUP SL. Datos registrales. T 40478 , F 105, S 8, H B 79221, I/A 33 (18.03.10).
Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"BESSERUP SL". Datos registrales. T 40478 , F 106, S 8, H B79221, I/A 34 (18.03.10).
03 de Febrero de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 157.396,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.061.641,00 Euros. Datos registrales. T 40478 ,F 102, S 8, H B 79221, I/A 31 (21.01.10).