Buscador CIF Logo

Actos BORME Facet Jewellery Solutions Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Facet Jewellery Solutions Sl

Actos BORME Facet Jewellery Solutions Sl - B63802789

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Cordoba para Facet Jewellery Solutions Sl con CIF B63802789

🔙 Perfil de Facet Jewellery Solutions Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cordoba

Actos BORME de Facet Jewellery Solutions Sl

14 de Agosto de 2023
Cambio de domicilio social. CTRA PALMA DEL RIO Km 3,3 - PARQUE JOYERO, FASE 05 (CORDOBA). Datos registrales. T2818 , F 146, S 8, H CO 43015, I/A 4 ( 4.08.23).

22 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: NT AUDIT SL. Datos registrales. T 2818 , F 146, S 8, H CO 43015, I/A 3 (15.12.22).

30 de Noviembre de 2021
Cambio de domicilio social. CTRA PALMA DEL RIO Km 3,3 - PARQUE JOYERO, FASE 03 (CORDOBA). Datos registrales. T2818 , F 145, S 8, H CO 43015, I/A 2 (24.11.21).

20 de Octubre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: NT AUDIT SL. Datos registrales. T 42385 , F 127, S 8, H B 298711, I/A 22 (11.10.21).

26 de Julio de 2021
Revocaciones. APODERAD.SOL: SAEZ ARAGAY GUILLEM. Datos registrales. T 42385 , F 127, S 8, H B 298711, I/A 21(16.07.21).

25 de Febrero de 2021
Revocaciones. APODERADO: RAMON SALMONA JAIME;GARROS ANGLES JAUME;QUER RIERA FRANCESC D'ASSIS.APODERAD.SOL: GARROS ANGLES JAUME. Datos registrales. T 42385 , F 127, S 8, H B 298711, I/A 20 (17.02.21).

18 de Febrero de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAUME. PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAUME. CONSEJERO: SERRETANTOLIN JOSE MIGUEL. VICEPRESIDEN: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL.CONSEJERO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO. SECRETARIO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO. CONSEJERO: RAMONSALMONA JAIME;QUER RIERA FRANCESC. Nombramientos. ADM.UNICO: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 17.- PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42385 ,F 126, S 8, H B 298711, I/A 19 (10.02.21).

03 de Febrero de 2021
Nombramientos. APODERAD.SOL: IBORRA MONTAGUT ANGEL. Datos registrales. T 42385 , F 125, S 8, H B 298711, I/A 18(26.01.21).

02 de Diciembre de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: SAEZ ARAGAY GUILLEM. Datos registrales. T 42385 , F 123, S 8, H B 298711, I/A 17(22.11.19).

16 de Abril de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: NT AUDIT SL. Datos registrales. T 42385 , F 122, S 8, H B 298711, I/A 16 ( 9.04.19).

15 de Febrero de 2019
Cambio de domicilio social. PZ EUROPA NUM.9-11 P.3 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datos registrales. T 42385 , F 122,S 8, H B 298711, I/A 15 ( 7.02.19).

23 de Febrero de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: NT AUDIT SL. Datos registrales. T 42385 , F 122, S 8, H B 298711, I/A 14 (16.02.16).

15 de Febrero de 2016
Nombramientos. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAUME. PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAUME. CONSEJERO: SERRETANTOLIN JOSE MIGUEL. VICEPRESIDEN: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL.CONSEJERO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO. SECRETARIO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO. CONSEJERO: RAMONSALMONA JAIME;QUER RIERA FRANCESC. Datos registrales. T 42385 , F 122, S 8, H B 298711, I/A 13 ( 8.02.16).

13 de Enero de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL;GARROS ANGLES JAUME. Datos registrales. T 42385 , F121, S 8, H B 298711, I/A 12 ( 2.01.15).

28 de Octubre de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 42385 , F 121, S 8, H B 298711, I/A 11 (21.10.13).

14 de Junio de 2013
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: NOVO AGUERO JAIME. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: NOVO AUDITORES SL. Datosregistrales. T 42385 , F 121, S 8, H B 298711, I/A 10 ( 7.06.13).

27 de Enero de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAIME;SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL;QUER RIERA FRANCESC D'ASSIS.PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAIME. SECRETARIO: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRET ANTOLINJOSE MIGUEL. Nombramientos. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAUME. PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAUME.CONSEJERO: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. VICEPRESIDEN: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRETANTOLIN JOSE MIGUEL. CONSEJERO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO;QUER RIERA FRANCESC D'ASSIS;RAMONSALMONA JAIME. SECRETARIO: MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 37427 , F 84, S 8, H B 298711, I/A 9(14.01.11).

25 de Agosto de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: NOVO AGUERO JAIME. Datos registrales. T 37427 , F 84, S 8, H B 298711, I/A 8 (16.08.10).

08 de Marzo de 2010
Revocaciones. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAUME. PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAUME. CONSEJERO: SERRETANTOLIN JOSE MIGUEL. SECRETARIO: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL.CONSEJERO: QUER RIERA FRANCESC D'ASSIS. Nombramientos. CONSEJERO: GARROS ANGLES JAIME;SERRET ANTOLINJOSE MIGUEL;QUER RIERA FRANCESC D'ASSIS. PRESIDENTE: GARROS ANGLES JAIME. SECRETARIO: SERRET ANTOLINJOSE MIGUEL. CONS. DELEG.: SERRET ANTOLIN JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 37427 , F 84, S 8, H B 298711, I/A 7(23.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información