Buscador CIF Logo

Actos BORME Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl

Actos BORME Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl - B45847837

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl con CIF B45847837

馃敊 Perfil de Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Factoria De Transformacion De Operaciones Y Servicios Sl

24 de Agosto de 2023
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1751 , F 49, S 8, H TO 37840, I/A 34 (17.08.23).

08 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE MANUEL SUAREZ VIEJO. Datos registrales. T 1751 , F 49, S 8, H TO 37840, I/A 33 (27.04.23).

29 de Diciembre de 2022
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: UNICAJA BANCO SA. Datos registrales. T 1751 , F 49, S 8, H TO37840, I/A 32 (21.12.22).

23 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: NURIA CANDIA PASTOR. Datos registrales. T 1723 , F 172, S 8, H TO 37840, I/A 28 (16.11.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: NURIA CANDIA PASTOR. Datos registrales. T 1723 , F 172, S 8, H TO 37840, I/A 29 (16.11.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: NURIA CANDIA PASTOR. Datos registrales. T 1723 , F 172, S 8, H TO 37840, I/A 30 (16.11.22).

Revocaciones. Apo.Manc.: JAIME PLEITE MARTIN. Nombramientos. Apo.Manc.: MARIO PEREZ AGUDO. Datos registrales. T1723 , F 172, S 8, H TO 37840, I/A 31 (16.11.22).

05 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANDIA PASTOR NURIA. Con.Delegado: CANDIA PASTOR NURIA. Nombramientos. Consejero:PI脩EIRO BASOA ALBERTO. Con.Delegado: PI脩EIRO BASOA ALBERTO. Datos registrales. T 1723 , F 172, S 8, H TO 37840, I/A27 (29.08.22).

20 de Enero de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: FUENTES VALDEOLIVAS BLANCA;GONZALEZ DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: GONZALEZDE LA FUENTE MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: MEJIA VALLEJO ISABEL. Datos registrales. T 1723 , F 171, S 8, H TO 37840, I/A 24(12.01.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ OLIVENZA MIRIAM. Datos registrales. T 1723 , F 171, S 8, H TO 37840, I/A 25(12.01.22).

Nombramientos. Apoderado: MORA-GRANADOS VILLARRUBIA IRENE. Datos registrales. T 1723 , F 171, S 8, H TO 37840, I/A26 (12.01.22).

28 de Octubre de 2021
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1723 , F 171, S 8, H TO 37840,I/A 23 (21.10.21).

04 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ PEREA JOSE MARIA;GUTIERREZ MORENO MARIA;MARTIN HERNANDEZ ANDRES;SANCHEZRAMON FERMIN. Nombramientos. Apo.Sol.: DE ROA HERNANDEZ ALVARO;RUIZ DE LA CRUZ ESTHER;PLEITE RODRIGUEZBEATRIZ;RICO GOMEZ DAVID;POLO HELLIN MARIA-ESTHER;PI脩EIRO BASOA ALBERTO. Datos registrales. T 1650 , F 223, S8, H TO 37840, I/A 20 (27.07.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ PEREA JOSE MARIA;GUTIERREZ MORENO MARIA;MARTIN HERNANDEZ ANDRES;SANCHEZRAMON FERMIN. Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO DE PAZ CLAUDIA;RUIZ DE LA CRUZ ESTHER;PLEITE RODRIGUEZBEATRIZ;RICO GOMEZ DAVID;POLO HELLIN MARIA-ESTHER;PI脩EIRO BASOA ALBERTO;DE ROA HERNANDEZ ALVARO;SOTOSERRANO RAQUEL. Datos registrales. T 1650 , F 223, S 8, H TO 37840, I/A 21 (27.07.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ MORENO MARIA;SANCHEZ RAMON FERMIN. Nombramientos. Apo.Sol.: DE ROAHERNANDEZ ALVARO;RUIZ DE LA CRUZ ESTHER;PLEITE RODRIGUEZ BEATRIZ;RICO GOMEZ DAVID;POLO HELLIN MARIA-ESTHER;PI脩EIRO BASOA ALBERTO. Datos registrales. T 1650 , F 223, S 8, H TO 37840, I/A 22 (27.07.21).

11 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: COBOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1650 , F 223, S 8, H TO 37840, I/A 19( 4.05.21).

09 de Octubre de 2020
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1650 , F 223, S 8, H TO 37840, I/A 18 ( 2.10.20).

07 de Mayo de 2020
Otros conceptos: Modificado el art铆culo 15 de los estatutos sociales relativo a la retribuci贸n del cargo de administrador. Datosregistrales. T 1650 , F 221, S 8, H TO 37840, I/A 17 (28.04.20).

25 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: FUENTES VALDEOLIVAS BLANCA. Datos registrales. T 1650 , F 221, S 8, H TO 37840, I/A 16(14.11.19).

22 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTES VALDEOLIVAS BLANCA. Apo.Manc.: FUENTES VALDEOLIVAS BLANCA;GONZALEZOLIVENZA MIRIAM;PLEITE MARTIN JAIME. Datos registrales. T 1634 , F 166, S 8, H TO 37840, I/A 15 (15.10.19).

17 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GREGORIO MIGUEL-ROMERO MARIA TERESA. Con.Delegado: DE GREGORIO MIGUEL-ROMERO MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: CANDIA PASTOR NURIA. Con.Delegado: CANDIA PASTOR NURIA.Datos registrales. T 1634 , F 166, S 8, H TO 37840, I/A 13 ( 9.08.18).

18 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: MEJIA VALLEJO ISABEL. Datos registrales. T 1634 , F 166, S 8, H TO 37840, I/A 12 (11.06.18).

08 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: GONZALEZ DE LA FUENTE MIGUELANGEL;FUENTES VALDEOLIVAS BLANCA. Datos registrales. T 1634 , F 166, S 8, H TO 37840, I/A 11 (28.05.18).

28 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLOSTA RIGO JOSE LUIS. Con.Delegado: BELLOSTA RIGO JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: DE GREGORIO MIGUEL-ROMERO MARIA TERESA. Con.Delegado: DE GREGORIO MIGUEL-ROMERO MARIATERESA. Datos registrales. T 1634 , F 165, S 8, H TO 37840, I/A 10 (13.02.18).

29 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1634 , F 165, S 8, H TO 37840, I/A 9 (22.01.18).

07 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: MENENDEZ PUJADAS JOSE JAVIER. Datos registrales. T 1634 , F 165, S 8, H TO 37840, I/A 8(30.11.17).

16 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLODRE PASTOR FAUSTO;PEREZ JIMENEZ MARTA;GOMEZ RODRIGUEZ JORGE;MARTINEZDIAZ ROSA ANA;PEREZ PECES MELCHOR;NU脩EZ JIMENEZ JOSE IGNACIO;CANDIA PASTOR NURIA;SANCHEZ RAMONFERMIN;ROZALEN DE LA TORRE ALVARO;GUTIERREZ MORENO MARIA. Datos registrales. T 1634 , F 165, S 8, H TO 37840,I/A 6 ( 8.06.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ALCOJOR MARIA DEL PRADO;MARTIN HERNANDEZ ANDRES;VILLODRE PASTORFAUSTO;PEREZ JIMENEZ MARTA;GOMEZ RODRIGUEZ JORGE;MARTINEZ DIAZ ROSA ANA;PEREZ PECES MELCHOR;NU脩EZJIMENEZ JOSE IGNACIO;CANDIA PASTOR NURIA;SANCHEZ RAMON FERMIN;ROZALEN DE LA TORRE ALVARO;GUTIERREZMORENO MARIA;GOMEZ PEREA JOSE MARIA. Datos registrales. T 1634 , F 165, S 8, H TO 37840, I/A 7 ( 8.06.17).

03 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ VIEJO JOSE MANUEL;FERNANDEZ ALCOJOR MARIA DEL PRADO;MARTIN HERNANDEZANDRES;VILLODRE PASTOR FAUSTO;PEREZ JIMENEZ MARTA;GOMEZ RODRIGUEZ JORGE;MARTINEZ DIAZ ROSAANA;PEREZ PECES MELCHOR;NU脩EZ JIMENEZ JOSE IGNACIO;CANDIA PASTOR NURIA;SANCHEZ RAMONFERMIN;ROZALEN DE LA TORRE ALVARO;GUTIERREZ MORENO MARIA;GOMEZ PEREA JOSE MARIA;MENENDEZ PUJADASJOSE JAVIER. Datos registrales. T 1612 , F 215, S 8, H TO 37840, I/A 5 (22.12.16).

12 de Mayo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.003.000,00 Euros. Datos registrales. T 1612 , F 215, S8, H TO 37840, I/A 4 ( 5.05.16).

25 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ADMINISTRADORA VALTENAS SL;CAMIN DE LA MESA SA. Nombramientos. Consejero:ADMINISTRADORA VALTENAS SL;MARTINEZ GARCIA IGNACIO;GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL;BELLOSTA RIGOJOSE LUIS. Presidente: ADMINISTRADORA VALTENAS SL. Secretario: MARTINEZ GARCIA IGNACIO. Con.Delegado: BELLOSTARIGO JOSE LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 1612 , F 214, S 8, H TO 37840, I/A 2 (18.01.16).

Nombramientos. Apoderado: COBOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1612 , F 214, S 8, H TO 37840, I/A3 (18.01.16).

11 de Diciembre de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.11.15. Objeto social: Servicios de consultor铆a, asesoramiento, formaci贸n, planificaci贸n,de organizaci贸n de empresas y contabilidad, administrativos, organizativos, operacionales, Inform谩ticos y de intermediaci贸n en lagesti贸n de cobro. Tenencia y administraci贸n de participaciones o acciones en sociedades. CNAE 7022. Domicilio: C/ OCA脩A 1(TOLEDO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LIBERBANK SA. Nombramientos. Adm.Solid.: CAMIN DE LA MESA SA;ADMINISTRADORA VALTENAS SL. Datos registrales. T 1612 , F 213, S 8, H TO 37840, I/A 1 (3.12.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n