Actos BORME de Fall Creek Farm & Nursery Europe Srl
08 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 7183 , F 53, S 8, H SE106075, I/A40 (30.10.23).
19 de Mayo de 2023Fe de erratas: El nombre del apoderdo es DENIS, no Penis. Datos registrales. T 6715 , F 147, S 8, H SE106075, I/A 29 ( 2.03.22).
Revocaciones. Apoderado: KIAT KWANE KOH DENIS. Datos registrales. T 7183 , F 53, S 8, H SE106075, I/A 39 ( 9.05.23).
24 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MONGE PABLO;RUFO RODRIGUEZ JOSE;BAENA CONDE JUANANTONIO;FERNANDEZ ROMERO MARIANO;BUIZA CALERO INES;LEON DE CACERES RAFAEL. Datos registrales. T 7183 , F52, S 8, H SE106075, I/A 38 (16.01.23).
29 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 7183 , F 52, S 8, H SE106075, I/A37 (21.12.22).
30 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. Asumir y llevar a cabo todas lasoperaciones, incluyendo servicios preparatorios y auxiliares, en relaci贸n con la producci贸n de plantas de ar谩ndanos en viveros propioso arrendados en Espa帽a, o fuera del territorio espa帽ol, y su comercializaci贸n nacional e internacional, as铆 como, la actividad de in.
19 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUELY BERTRAND CLAUDE MARIE. Datos registrales. T 7183 , F 51, S 8, H SE106075, I/A 34 (5.04.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: MAHON ARAGON EVA MARIA. Datos registrales. T 7183 , F 52, S 8, H SE106075, I/A 35 ( 5.04.22).
05 de Abril de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 7183 , F 50, S 8, H SE106075,I/A 31 (25.03.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: BUIZA CALERO INES;MUNK SABINE. Datos registrales. T 7183 , F 50, S 8, H SE106075, I/A 32(25.03.22).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: TALCOTT AUST AMELIE. Nombramientos. Adm. Solid.: VERGES HERANZ OSCAR. Datosregistrales. T 7183 , F 51, S 8, H SE106075, I/A 33 (25.03.22).
16 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: KIAT KWANE KOH PENIS;BEATRICE MUNK SABINE. Datos registrales. T 6715 , F 147, S 8, HSE106075, I/A 29 ( 2.03.22).
Nombramientos. Apoderado: VAN DYK BURGERT. Datos registrales. T 6715 , F 148, S 8, H SE106075, I/A 30 ( 2.03.22).
15 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: TIRADO MONAGE FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 6715 , F 146, S 8, H SE106075, I/A 27( 4.11.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BUIZA CALERO INES. Datos registrales. T 6715 , F 146, S 8, H SE106075, I/A 28 ( 4.11.21).
05 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6715 , F 146, S 8, H SE106075, I/A26 (28.10.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: TIRADO MONAGE FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 6715 , F 145, S 8, H SE106075, I/A25 (30.07.20).
06 de Septiembre de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 3.- Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. CMNO PARTIDODE RESINA Km 2,5 - FINCA BUENA VENTUR (AZNALCAZAR). Datos registrales. T 6715 , F 145, S 8, H SE106075, I/A 24(28.08.19).
01 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO UGARTE JOSE MARIA;WILLIAM BASTOW PATRICK. Datos registrales. T 6715 , F 143, S8, H SE106075, I/A 21 (24.07.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO UGARTE JOSE MARIA;ALAMO BERMUDO ANTONIO ABAD. Datos registrales. T 6715, F 143, S 8, H SE106075, I/A 22 (24.07.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALAMO BERMUDO ANTONIO ABAD;MORENO UGARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6715, F 144, S 8, H SE106075, I/A 23 (24.07.19).
31 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MELTON BRAZELTON DAVID. Nombramientos. Adm. Solid.: MCLOUD BRAZELTONCORT;TALCOTT AUST AMELIE. Modificaciones estatutarias. 8. Organo de administraci贸n. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 6052 , F 209, S 8, H SE106075, I/A15 (23.05.19).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BRAZELTON CORT;ABAD ALAMO BERMUDO ANTONIO. Apo.Sol.: BRAZELTON CORT MCLOUD.Apoderado: MORENO UGARTE JOSE MARIA;MAHON ARAGON EVA MARIA. Apo.Manc.: MORENO UGARTE JOSE MARIA;ABADALAMO BERMUDO ANTONIO. Datos registrales. T 6052 , F 210, S 8, H SE106075, I/A 16 (23.05.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAHON ARAGON EVA MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 210, S 8, H SE106075, I/A 17 (23.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: WILLIAM BASTOW PATRICK. Datos registrales. T 6715 , F 140, S 8, H SE106075, I/A 18(24.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO UGARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6715 , F 140, S 8, H SE106075, I/A 19(24.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUELY BERTRAND CLAUDE MARIE. Datos registrales. T 6715 , F 142, S 8, H SE106075, I/A 20(24.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: WEIMANN GOMEZ MONICA;SANCHEZ WEICKGANANNT CRISTINA;SCHAAR ORIVESAMARA;MORENO UGARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 209, S 8, H SE106075, I/A 14 (26.03.19).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6052 , F 208, S 8, H SE106075,I/A 12 (28.12.17).
Nombramientos. Apoderado: MAHON ARAGON EVA MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 209, S 8, H SE106075, I/A 13(29.12.17).
14 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: INFANTE PEREA ANTONIO. Datos registrales. T 6052 , F 208, S 8, H SE106075, I/A 10 ( 3.11.17).
Nombramientos. Apoderado: MORENO UGARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 208, S 8, H SE106075, I/A 11 (3.11.17).
05 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO UGARTE JOSE MARIA;ABAD ALAMO BERMUDO ANTONIO. Datos registrales. T 6052 , F207, S 8, H SE106075, I/A 9 (28.08.17).
10 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: MAHON ARAGON EVA MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 207, S 8, H SE106075, I/A 8 (31.07.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: VERGES HERANZ OSCAR. Datos registrales. T 6052 , F 205, S 8, H SE106075, I/A 7 (12.01.17).
11 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: BRAZELTON CORT MCLOUD;AUST BORIS. Datos registrales. T 6052 , F 204, S 8, H SE106075, I/A 4( 2.03.16).
Nombramientos. Apoderado: MORENO UGARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6052 , F 204, S 8, H SE106075, I/A 5 (2.03.16).
Nombramientos. Apoderado: INFANTE PEREA ANTONIO. Datos registrales. T 6052 , F 204, S 8, H SE106075, I/A 6 ( 2.03.16).
24 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 4. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ VICENTE ALEXANDRE 12(VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA). Datos registrales. T 6052 , F 203, S 8, H SE106075, I/A 3 (16.12.15).
28 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRAZELTON CORT;AUST BORIS;ABAD ALAMO BERMUDO ANTONIO. Datos registrales. T 6052, F 202, S 8, H SE106075, I/A 2 (17.07.15).
24 de Julio de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.06.15. Objeto social: es asumir y llevar a cabo todas las operaciones, incluyendoservicios preparatorios y auxiliares en relaci贸n a la producci贸n de ar谩ndanos en viveros en Europa.- CNAE PRINCIPAL 0161.-Domicilio: C/ CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS 4 8& - CODIGO PO (SEVILLA). Capital: 5.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: FALL CREEK EUROPE LLC. Nombramientos. Adm. Unico: MELTON BRAZELTON DAVID. Datosregistrales. T 6052 , F 201, S 8, H SE106075, I/A 1 (15.07.15).