Actos BORME de Fandicosta Sa
16 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS FANDI脩O ALFONSO. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 180, S 8, H PO 13094, I/A 60 (
20 de Octubre de 2020Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T4248, L 4248, F 180, S 8, H PO 13094, I/A 58 ( 9.10.20).
19 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOS ALFREDO JOAQUIN.Apo.Man.Soli: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOSALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;FERNANDEZ RIVEIRO LUIS. Datosregistrales. T 4248, L 4248, F 179, S 8, H PO 13094, I/A 57 (10.08.20).
10 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ VARELA ANGEL;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;FERNANDEZ RIVEIROLUIS;MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 179, S 8, H PO 13094, I/A 56 ( 2.07.20).
11 de Mayo de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.495.590,00 Euros. Desembolsado: 1.495.590,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.452.600,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.452.600,00 Euros. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 177, S 8, H PO 13094, I/A 53 (29.04.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ VARELA ANGEL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ VARELA ANGEL.Presidente: MARTINEZ VARELA ANGEL. Consejero: XESGALICIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERS;MOSQUERARUIZ ADRIAN. SecreNoConsj: PIORNO GONZALEZ JULIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 178, S 8, H PO 13094, I/A 54 (29.04.20).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 691.910,00 Euros. Desembolsado: 691.910,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.144.510,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.144.510,00 Euros. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 178, S 8, H PO 13094, I/A 55 (29.04.20).
17 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 177, S 8, H PO 13094,I/A 52 ( 5.02.20).
28 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;FERNANDEZ RIVEIRO LUIS. Datos registrales. T 4248, L4248, F 176, S 8, H PO 13094, I/A 51 (20.01.20).
20 de Septiembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.431.340,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.957.010,00 Euros. Datos registrales. T 4248,L 4248, F 176, S 8, H PO 13094, I/A 50 (13.09.19).
29 de Julio de 2019Revocaciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORESSLP. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 175, S 8, H PO 13094, I/A 49 (18.07.19).
28 de Marzo de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9,17 Euros. Desembolsado: 9,17 Euros. Resultante Suscrito: 4.388.350,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 4.388.350,00 Euros. Datos registrales. T 4248, L 4248, F 175, S 8, H PO 13094, I/A 48 (18.03.19).
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;MARTINEZ VARELA ANGEL;BRUNET GARCIA JUAN CARLOS.Presidente: MARTINEZ VARELA ANGEL. SecreNoConsj: PIORNO GONZALEZ JULIO. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZVARELA ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 4248, L 4248, F 175, S 8, H PO 13094, I/A 47 (18.12.18).
24 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: AUSTER SERVICIOS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGI. Presidente: AUSTER SERVICIOSDE GESTION E INNOVACION TECNOLOGI. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ VARELA ANGEL. Consejero: MARTINEZVARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 221, S 8, H PO 13094, I/A 45 (20.08.18).
Revocaciones. Apoderado: FANDI脩O LORENZO ELISARDO;FANDI脩O LORENZO ELISARDO;RODRIGUEZ ESCALADA JESUSCESAR Datos registrales. T 4248, L 4248, F 175, S 8, H PO 13094, I/A 46 (20.08.18).
26 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 221, S 8, H PO13094, I/A 44 (15.06.17).
13 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;TENORIO RIVEIRO BORJA. Nombramientos. Consejero:BRUNET GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 221, S 8, H PO 13094, I/A 43 ( 4.10.16).
24 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: MATEO COSTAS MAXIMO JESUS. Apo.Sol.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTASMAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOS ALFREDO JOAQUIN;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS. Apo.Man.Soli:MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOS ALFREDOJOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL. Apo.Manc.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMOJESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL;MARTINEZ SOBREIRARICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOS SANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELAANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 220, S 8, H PO 13094, I/A 41 (16.06.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;CAMPUZANO PEREIRA DOSSANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 220, S 8, H PO 13094, I/A 42(16.06.16).
15 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BARREIRO NU脩EZ ALBERTO;GANDON HERBELLO MARIA. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 220, S 8, H PO 13094,I/A 40 ( 5.02.16).
18 de Enero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.549,24 Euros. Resultante Suscrito: 4.388.340,83 Euros. Datos registrales. T 1535, L1535, F 219, S 8, H PO 13094, I/A 39 (11.01.16).
16 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOSSANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 219, S 8, H PO 13094, I/A 38 (8.01.15).
02 de Septiembre de 2014Nombramientos. Aud.C.Con.: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 219, S 8, HPO 13094, I/A 37 (22.08.14).
20 de Marzo de 2014Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 219, S 8, H PO 13094, I/A 35(11.03.14).
Nombramientos. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 219, S 8, H PO13094, I/A 36 (11.03.14).
21 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOSSANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 218, S 8, H PO 13094, I/A 34(14.02.14).
19 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ VARELA ANGEL. Presidente: MARTINEZ VARELA ANGEL. Nombramientos.Consejero: AUSTER SERVICIOS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGI. Presidente: AUSTER SERVICIOS DE GESTION EINNOVACION TECNOLOGI. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 218, S 8, H PO 13094, I/A 33 (12.02.14).
17 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GANDON MENDUI脩A MANUEL. Nombramientos. Consejero: GANDON HERBELLO MARIA.Datos registrales. T 1535, L 1535, F 218, S 8, H PO 13094, I/A 32 (11.02.14).
28 de Enero de 2013Reelecciones. Adm. Unico: MARTINEZ VARELA ANGEL. Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17,18,19, 20, 21 y 24 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 163, S 8, H PO 13094, I/A 29 (21.01.13).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ VARELA ANGEL. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ VARELA ANGEL.Consejero: MARTINEZ VARELA ANGEL;GANDON MENDUI脩A MANUEL;BARREIRO NU脩EZ ALBERTO;TENORIO RIVEIRO BORJA.SecreNoConsj: PIORNO GONZALEZ JULIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 163, S 8, H PO 13094, I/A 30 (21.01.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRADOS SANTOS ALFREDO JOAQUIN;MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 217, S 8, H PO 13094, I/A 31(21.01.13).
17 de Febrero de 2012Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP;NOSTRUM AUDITORES SLP.Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 163, S 8, H PO 13094, I/A 28 (7.02.12).
22 de Junio de 2011Otros conceptos: Se acuerda la modificaci贸n del Art铆culo 7潞 de los EstatutosSociales relativo a la transmisi贸n de acciones. Datosregistrales. T 1535, L 1535, F 162, S 8, H PO 13094, I/A 27 ( 9.06.11).
28 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOSSANTOS ALFREDO. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 162, S 8, H PO 13094, I/A 26 (16.03.11).
23 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ SOBREIRA RICARDO;MATEO COSTAS MAXIMO JESUS;CAMPUZANO PEREIRA DOSSANTOS ALFREDO. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 162, S 8, H PO 13094, I/A 25 (10.06.10).
03 de Septiembre de 2009Reelecciones. Adm. Unico: MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 161, S 8, H PO 13094, I/A 24(24.08.09).
04 de Marzo de 2009Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 14.- ADMINISTRADOR UNICO. A) NUMERO DE ADMINISTRADORES. 1.- La sociedadestar谩 regida y administrada por un Administrador 煤nico. B) NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL CARGO DEADMINISTRADORUNICO. 1.- El Administrador 煤nico ser谩 nombrado por la Junta General, sin que sea necesario que ostente la. Otros conceptos: EnJunta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el d铆a 08-02-2008, se acord贸: Modificar el Art铆culo 14 de losEstatutos Sociales.FE DE ERRATAS: SE ENVIAN PARA SU PUBLICACION LOS DATOS DE LA INSCRIPCION 22&, HABIENDOSECOMPROBADO QUE POR ERROR DE PROCEDIMIENTO NO FUERON ENVIADOS A PUBLICAR EN SU DIA. Datos registrales. T1535, L 1535, F 161, S 8, H PO 13094, I/A 22 (31.03.08).
12 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1535, L 1535, F 161, S 8, H PO 13094, I/A 23(26.12.08).