Actos BORME de Fantuzzi Noell Iberia Sl
28 de Febrero de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 84, S 8, H V 89004, I/A 19 (21.02.18).
19 de Mayo de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: KONECRANES IBERICA SL. Datos registrales. T 7442, L 4743, F84, S 8, H V 89004, I/A 18 (11.05.17).
27 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: COHEN ERIC;BRADLEY KEVIN PATRICK. Vicepresid.: COHEN ERIC. Secretario: BELZUZFERNANDEZ ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: COHEN ERIC I;BRADLEY KEVIN PATRICK;COHEN ERIC I;BRADLEYKEVIN PATRICK;JOHN SMITH GRAHAM. Nombramientos. Consejero: LEHTINEN AKU;NU脩EZ ARENAS VILLARES ANGEL.Secretario: GIL ROIG RAMON. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 84, S 8, H V 89004, I/A 17 (20.03.17).
21 de Septiembre de 2016Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del RegistroMercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion. Datosregistrales. T 7442, L 4743, F 30, S 8, H V 89004, I/A 15 (14.09.16).
Revocaciones. Apoderado: SAURO DAVIDE BERTOZZI. Apo.Man.Soli: LINO USEDO MARIA TERESA;LINO USEDO MARIATERESA. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 30, S 8, H V 89004, I/A 16 (14.09.16).
19 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALEXANDER RODETIS GREGORY. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 29, S 8, H V 89004, I/A 14(12.04.16).
05 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: COHEN ERIC I;BRADLEY KEVIN PATRICK;PETER HOFFMANN KLAUS;JOHN SMITHGRAHAM;ALEXANDER RODETIS GREGORY;MOSQUERA ROMERO ALFONSO;LINO USEDO MARIA TERESA;RODRIGUEZGARCIA MARIA JOSE;MELLI ORTEGA RODRIGO;MARIANO BERNARDO FELIX. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 29, S 8, H V89004, I/A 13 (29.10.15).
04 de Noviembre de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 29, S 8, H V89004, I/A 12 (28.10.15).
07 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: LINO USEDO MARIA TERESA;COHEN ERIC I;BRADLEY KEVIN PATRICK;HOFFMANN KLAUSPETER;MOSQUERA ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 28, S 8, H V 89004, I/A 11 (30.09.14).
23 de Enero de 2014Cambio de domicilio social. AVDA DE LA CONSTITUCION 30 (MUSEROS). Datos registrales. T 7442, L 4743, F 27, S 8, H V89004, I/A 10 (16.01.14).
06 de Agosto de 2013Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2011 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 27, S 8, H V 89004, I/A 8 (30.07.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: WIDMAN PHILIP. Nombramientos. Consejero: BRADLEY KEVIN PATRICK. Datos registrales. T7442, L 4743, F 27, S 8, H V 89004, I/A 9 (30.07.13).
19 de Diciembre de 2012Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2011 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 26, S 8, H V89004, I/A 6 (12.12.12).
Otros conceptos: El socio 煤nico de la sociedad de esta hoja, la entidad "Reggiane Cranes and Plants SPA, ha transformado su formajuridica de una sociedad por acciones a una sociedad limitada y hamodificado su denominaci贸n por la de "TEREX OPERATIONSITALY, SRL" en virtud de escritura de fecha 27 de junio de 2012. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 26, S 8, H V 89004, I/A 4 M(12.12.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PATRICK BRADLEY KEVIN. Presidente: PATRICK BRADLEY KEVIN. Con.Delegado: PATRICKBRADLEY KEVIN. Nombramientos. Consejero: HOFFMANN KLAUS PETER. Presidente: HOFFMANN KLAUS PETER.Con.Delegado: HOFFMANN KLAUS PETER. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 27, S 8, H V 89004, I/A 7 (12.12.12).
28 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: OSTERMANN THOMAS. Con.Delegado: OSTERMANN THOMAS. Consejero: OSTERMANNTHOMAS. Nombramientos. Consejero: PATRICK BRADLEY KEVIN. Presidente: PATRICK BRADLEY KEVIN. Con.Delegado:PATRICK BRADLEY KEVIN. Datos registrales. T 7442, L 4743, F 26, S 8, H V 89004, I/A 5 (19.12.11).
08 de Abril de 2010Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: REGGIANE CRANES AND PLANTS SPA. Ceses/Dimisiones.Consejero: PAOLO DAZI;VINCENZO PEZZOULI. Vicepresid.: VINCENZO PEZZOULI. Secretario: PAOLO DAZI. Consejero: PAGANIMICHELE. Presidente: PAGANI MICHELE. Revocaciones. Apoderado: SAURO DAVIDE BERTOZZI;PAOLO DAZI;VINCENZOPEZZOULI. Nombramientos. Secretario: BELZUZ FERNANDEZ ENRIQUE. Consejero: OSTERMANN THOMAS;COHENERIC;WIDMAN PHILIP. Presidente: OSTERMANN THOMAS. Con.Delegado: OSTERMANN THOMAS. Datos registrales. T 7442, L4743, F 26, S 8, H V 89004, I/A 4 (26.03.10).