Buscador CIF Logo

Actos BORME Farmalider Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Farmalider Sa

Actos BORME Farmalider Sa - A78285301

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Farmalider Sa con CIF A78285301

馃敊 Perfil de Farmalider Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Farmalider Sa

22 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Consejero: MATESANZ MARTIN CAROLINA;BERENGUERMU脩OZ MARIA-LUISA;BERENGUER HUERTAS JOSE LUISCons.Del.Sol: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Presidente:BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS;BERENGUER MU脩OZMARIA-LUISA;EISLEBEN SL;LAUREL ADVISORS SL;LOFTUS SL;WHITLEY SL;3-GUTINVER SL. Presidente: BERENGUERHUERTAS JOSE LUIS. Vicepresid.: LOFTUS SL. Con.Delegado: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA. Apoderado: BERENGUERHUERTAS JOSE LUIS. SecreNoConsj: FERNANDEZ RA脩ADA LOPEZ DORIGA JOSE. Representan: DE ARAGON GONZALEZENRIQUE JORGE;HERNANDEZ FERNANDEZ CRISTINA;PELAEZ COLLADO ANDRES;NU脩EZ CABEZON RAMON;GUTIERREZFUENTES LUIS GERARDO. Modificaciones estatutarias. 1. Refundici贸n de estatutos sociales.. Datos registrales. T 39245 , F 12,S 8, H M 437206, I/A 36 (15.09.23).

27 de Octubre de 2022
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39245 , F 12, S 8, H M437206, I/A 35 (20.10.22).

21 de Febrero de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39245 , F 12, S 8, H M437206, I/A 33 (14.02.22).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39245 , F 12, S 8, H M 437206, I/A34 (14.02.22).

12 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN LILL SADIE MARK JAMES. Datos registrales. T 39245 , F 12, S 8, H M 437206, I/A 32 (3.11.21).

19 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: VALDES ACITORES GONZALO FERMIN. Datos registrales. T 39245 , F 11, S 8, H M 437206, I/A 31(12.04.21).

02 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUTTER KIERON. Nombramientos. Consejero: VAN LILL SADIE MARK JAMES. Reelecciones.Consejero: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA;BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: BERENGUER HUERTASJOSE LUIS. Presidente: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 39245 , F 11, S 8, H M 437206, I/A 30 (23.02.21).

10 de Junio de 2019
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39245 , F 11, S 8, H M 437206,I/A 29 ( 3.06.19).

07 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DELGADO MARIA ISABEL;GONZALEZ DELGADO JULIA. Cons.Del.Sol: GONZALEZDELGADO MARIA ISABEL. Presidente: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA. Consejero: LORENZO SAN MARTIN MIGUEL ANGEL.SecreNoConsj: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Consejero: WELLNER KARSTEN UWE HARALD HORST;RUBIO FRANCOMANRIQUE. Secretario: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Nombramientos. Consejero: WELLNER KARSTEN UWE HARALDHORST;LORENZO SAN MARTIN MIGUEL ANGEL. Presidente: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Consejero: RUBIO FRANCOMANRIQUE. Secretario: RUBIO FRANCO MANRIQUE. SecreNoConsj: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Consejero: MATESANZMARTIN CAROLINA;FUTTER KIERON. Reelecciones. Consejero: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA;BERENGUER HUERTASJOSE LUIS. Cons.Del.Sol: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. SecreNoConsj: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Datos registrales. T24314 , F 30, S 8, H M 437206, I/A 28 (31.05.19).

27 de Noviembre de 2015
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Modificaci贸n del art铆culo 30潞 de los Estatutos sociales. Cambiode domicilio social. C/ LA GRANJA 1 - 3& PLANTA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 24314 , F 30, S 8, H M 437206, I/A 27(18.11.15).

21 de Julio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ REDONDO ANA MARIA. Datos registrales. T 24314 , F 29, S 8, H M 437206, I/A 25 (13.07.15).

Nombramientos. Apoderado: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA. Datos registrales. T 24314 , F 29, S 8, H M 437206, I/A 26(13.07.15).

07 de Julio de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 44.234,49 Euros. Resultante Suscrito: 208.190,59 Euros. Datos registrales. T 24314 , F29, S 8, H M 437206, I/A 24 (30.06.15).

19 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDO REAL ESTHER. Datos registrales. T 24314 , F 28, S 8, H M 437206, I/A 23 (12.12.14).

04 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: VALDES ACITORES GONZALO FERMIN. Datos registrales. T 24314 , F 28, S 8, H M 437206, I/A 22(27.11.14).

22 de Julio de 2014
Nombramientos. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 24314 , F 28, S 8, H M 437206, I/A 21 (14.07.14).

04 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: VAIDYALINGAM IYER SAINATH. Datos registrales. T 24314 , F 28, S 8, H M 437206, I/A 20 (28.05.14).

27 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: FERNANDEZ GARCIA LUIS MARIANO. Cons.Del.Sol: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA.Nombramientos. SecreNoConsj: RUBIO FRANCO MANRIQUE. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DELGADO MARIAISABEL;GONZALEZ DELGADO JULIA;BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISAPresidente: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA.Cons.Del.Sol: GONZALEZ DELGADO MARIA ISABEL. Consejero: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: BERENGUERHUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 24314 , F 27, S 8, H M 437206, I/A 19 (19.03.14).

12 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: VAIDYALINGAM IYER SAINATH. Datos registrales. T 24314 , F 26, S 8, H M 437206, I/A 18 (3.12.12).

03 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Consejero: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Con.Delegado: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 24314 , F 26, S 8, H M 437206, I/A 17 (22.08.12).

31 de Agosto de 2012
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 12& EL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIONO CONSEJERODE GARCIA FERNANDEZ LUIS MARIANO, SIENDO LO CORRECTO FERNANDEZ GARCIA LUIS MARIANO. Datos registrales. T24314 , F 22, S 8, H M 437206, I/A 12 (29.02.12).

04 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ CALVO ANTONIA;HERNANDO REAL ESTHER. Datos registrales. T 24314 , F 25, S 8, H M437206, I/A 16 (23.03.12).

03 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 24314 , F 24, S 8, H M 437206, I/A 14(22.03.12).

Nombramientos. Apoderado: GORDO GOYA GERARDO. Datos registrales. T 24314 , F 25, S 8, H M 437206, I/A 15 (22.03.12).

02 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GONZALEZ CRISTINA. Datos registrales. T 24314 , F 23, S 8, H M 437206, I/A 13(20.03.12).

12 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Presidente: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS.Con.Delegado: BERENGUER HUERTAS JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA.Presidente: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA. Cons.Del.Sol: BERENGUER MU脩OZ MARIA-LUISA;GONZALEZ DELGADOMARIA ISABEL. Reelecciones. Secretario: GARCIA FERNANDEZ LUIS MARIANO. Consejero: GONZALEZ DELGADO MARIAISABEL;GONZALEZ DELGADO JULIA. Datos registrales. T 24314 , F 22, S 8, H M 437206, I/A 12 (29.02.12).

03 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ REDONDO ANA MARIA. Datos registrales. T 24314 , F 22, S 8, H M 437206, I/A 11(22.12.10).

04 de Octubre de 2010
Nombramientos. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 24314 , F 22, S 8, H M 437206, I/A 10 (22.09.10).

22 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ REDONDO ANA MARIA. Datos registrales. T 24314 , F 22, S 8, H M 437206, I/A 9 (7.04.09).

12 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DELGADO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 24314 , F 21, S 8, H M 437206, I/A 8 (

29 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ DELGADO MARIA ISABEL. Apoderado: JIMENEZ REDONDO ANA MARIA. Datosregistrales. T 24314 , F 21, S 8, H M 437206, I/A 7 (19.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n