Buscador CIF Logo

Actos BORME Fashion Auction Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fashion Auction Spain Sl

Actos BORME Fashion Auction Spain Sl - B85757847

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fashion Auction Spain Sl con CIF B85757847

馃敊 Perfil de Fashion Auction Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fashion Auction Spain Sl

20 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TENDAM RETAIL SA. Representan: MIQUEL NAUDI JAIME. Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZOTERO MANUEL;AMOROS VILA RAMON;SERRANO MU脩OZ MANUEL;CONCHILLO ARMENDARIZ FEDERICO;MURIES FENOLLLAURA;TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO;SENDAGORTA CUDOS ALVARO. Nombramientos. Liquidador:TENDAM RETAIL SA. Representan: MIQUEL NAUDI JAUME. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 34163 , F128, S 8, H M 485951, I/A 18 (13.01.20).

15 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ OTERO MANUEL;AMOROS VILA RAMON;SERRANO MU脩OZ MANUEL;CONCHILLOARMENDARIZ FEDERICO;MURIES FENOLL LAURA;TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO;SENDAGORTACUDOS ALVARO. Datos registrales. T 34163 , F 127, S 8, H M 485951, I/A 17 ( 7.03.18).

05 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: HOEDL EIGEL CHRISTIAN;TORREGROSA BLANCHART ELENA;VELON NAVARRO ANA. Apoderado:MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO PABLO;JALVO MARTIN CARLOS;SIERRA ARMAS IGNACIO;GOMEZ GARCIAMARCOS;MOLINA SEIJO PALOMA;SANZ CORRAL JOSE MARIA;CHAROLA GARCIA-PARRE脩O DIEGO;GONZALEZ CORTEZON

13 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34163 , F 126, S 8, H M 485951, I/A 15 ( 2.11.17).

09 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL;DE SERDIO FERNANDEZ RICARDO;LOPEZDE GUZMAN PEDRO. Representan: TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:CORTEFIEL SOCIEDAD ANONIMA. Representan: MIQUEL NAUDI JAIME. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 34163 , F 126, S 8, H M 485951, I/A 14 (2.10.17).

12 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34163 , F 125, S 8, H M 485951, I/A 13 ( 4.01.17).

11 de Enero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MESA PALOMINO LUIS;CAMPOS PEREZ RAFAEL;ALBERTOS ROGERO JUAN PABLO;GONZALEZCORTEZON ANTONIO;SIERRA ARMAS IGNACIO;GOMEZ GARCIA MARCOS;SZAFIR EZEQUIEL;ESCRIBANO GARCIA JUANCARLOS;TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO;DE SERDIO FERNANDEZ RICARDO;ECHECOPAR ALVAREZANDRES. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO PABLO;JALVO MARTINCARLOS;SIERRA ARMAS IGNACIO;GOMEZ GARCIA MARCOS;MOLINA SEIJO PALOMA;SANZ CORRAL JOSE MARIA;CHAROLAGARCIA-PARRE脩O DIEGO;GONZALEZ CORTEZON ANTONIO;MESA PALOMINO LUIS;GONZALEZ HERRERO LUIS;SANCHEZRODILLA IGNACIO;CAMPOS PEREZ RAFAEL;ALBERTOS ROGERO JUAN PABLO;DE JAIME GUIJARRO JAVIER;MALLOALVAREZ CARLOS;PARIS MICHEL MAURICE;TORRE DE SILVA Y LOPEZ JOSE ANTONIO;DE SERDIO FERNANDEZRICARDO;LOPEZ DE GUZMAN PEDRO. Datos registrales. T 26969 , F 128, S 8, H M 485951, I/A 12 (29.12.15).

29 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26969 , F 128, S 8, H M 485951, I/A 11 (22.10.15).

22 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26969 , F 128, S 8, H M 485951, I/A 10 (15.10.14).

03 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26969 , F 128, S 8, H M 485951, I/A 9 (25.09.13).

17 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ECHECOPAR ALVAREZ ANDRES. Nombramientos. Adm. Solid.: LOPEZ DE GUZMAN PEDRO.Datos registrales. T 26969 , F 127, S 8, H M 485951, I/A 8 ( 7.06.13).

19 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26969 , F 127, S 8, H M 485951, I/A 7 ( 9.10.12).

29 de Marzo de 2011
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26969 , F 127, S 8, H M 485951, I/A 6 (10.03.11).

14 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: MESA PALOMINO LUIS;CAMPOS PEREZ RAFAEL;ALBERTOS ROGERO JUAN PABLO;GONZALEZCORTEZON ANTONIO;SIERRA ARMAS IGNACIO;GOMEZ GARCIA MARCOS;SZAFIR EZEQUIEL;ESCRIBANO GARCIA JUANCARLOS;TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO;DE SERDIO FERNANDEZ RICARDO;ECHECOPAR ALVAREZANDRES. Datos registrales. T 26969 , F 126, S 8, H M 485951, I/A 5 ( 4.05.10).

16 de Noviembre de 2009
Cambio de domicilio social. AVDA DEL LLANO CASTELLANO 51 (MADRID). Datos registrales. T 26969 , F 126, S 8, H M485951, I/A 4 ( 3.11.09).

10 de Noviembre de 2009
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORTEFIEL SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 26969 , F126, S 8, H M 485951, I/A 3 (28.10.09).

02 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: HOEDL EIGEL CHRISTIAN;TORREGROSA BLANCHART ELENA;VELON NAVARRO ANA. Datosregistrales. T 26969 , F 125, S 8, H M 485951, I/A 2 (22.09.09).

29 de Septiembre de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.08.09. Objeto social: Fabricaci贸n, compraventa y, en general, cualquier clase de comercio,al por menor y al por mayor o cualquier industria relacionados con toda clase dehilos, tejidos,. Domicilio: C/ JOSE ABASCAL 19 2潞 -IZQUIERDA (MADRID). Capital: 1.000.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FASHION AUCTION SARL.Nombramientos. Adm. Solid.: THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL;ECHECOPAR ALVAREZ ANDRES;DE SERDIOFERNANDEZ RICARDO. Representan: TORRE DE SILVA Y LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 26969 , F120, S 8, H M 485951, I/A 1 (17.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n