Buscador CIF Logo

Actos BORME Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl

Actos BORME Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl - B88396775

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl con CIF B88396775

馃敊 Perfil de Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fcc Medio Ambiente Reino Unido Sl

27 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: TAYLOR PAUL. Datos registrales. T 39467 , F 91, S 8, H M 693100, I/A 29 (21.11.23).

18 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE.Datos registrales. T 39467 , F 84, S 8, H M 693100, I/A 27 (11.04.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: COLIO ABRIL PABLO. Nombramientos. Apoderado: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 39467 ,F 87, S 8, H M 693100, I/A 28 (11.04.23).

04 de Febrero de 2022
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39467 , F 84, S 8, HM 693100, I/A 26 (28.01.22).

13 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 39467 , F 84, S 8, H M 693100, I/A 25 (2.12.21).

23 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 39467 , F 83, S 8, H M 693100, I/A 24(16.02.21).

01 de Febrero de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39467 , F 83, S 8, H M 693100, I/A 23 (25.01.21).

15 de Octubre de 2020
Nombramientos. Consejero: ORTS LLOPIS VICENTE. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 1陋 la publicaci贸n delnombramiento del consejero ORTS LLOPIS VICENTE. Datos registrales. T 39005 , F 170, S 8, H M 693100, I/A 1 (27.06.19).

24 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: CORRALES SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 39467 , F 82, S 8, H M 693100, I/A 22(17.08.20).

21 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 39467 , F 81, S 8, H M 693100, I/A 21(14.02.20).

20 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ DE VIVAR JIMENEZ MARIA ISABEL. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZBARRANCO CRISTINA. VsecrNoConsj: SANCHEZ DE VIVAR JIMENEZ MARIA ISABEL. Reelecciones. Vicepresid.: COLIO ABRILPABLO. Datos registrales. T 39467 , F 80, S 8, H M 693100, I/A 19 (13.01.20).

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 23潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 39467 ,F 81, S 8, H M 693100, I/A 20 (13.01.20).

08 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: TORRES BADAJOZ ANGEL MARIA. Datos registrales. T 39005 , F 178, S 8, H M 693100, I/A 4(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39005 , F 179, S 8, H M 693100, I/A 5(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: LIEBANA ALCANTARILLA JOSE. Datos registrales. T 39005 , F 180, S 8, H M 693100, I/A 6(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: CARRASCO DELGADO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 39005 , F 181, S 8, H M 693100, I/A 7(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: SUAREZ ZARCOS LUIS. Datos registrales. T 39005 , F 182, S 8, H M 693100, I/A 8 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: RICOTE GARBAJOSA JUAN. Datos registrales. T 39467 , F 66, S 8, H M 693100, I/A 9 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LOPEZ JUAN OSCAR. Datos registrales. T 39467 , F 69, S 8, H M 693100, I/A 10 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: CALDERON SARDINA JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 39467 , F 70, S 8, H M 693100, I/A11 (31.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ PORTAL JUSTO PRUDENCIO. Datos registrales. T 39467 , F 72, S 8, H M 693100, I/A12 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: PALOMERO SANCHEZ FELIX. Datos registrales. T 39467 , F 73, S 8, H M 693100, I/A 13 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ALCAZAR MIGUEL. Datos registrales. T 39467 , F 75, S 8, H M 693100, I/A 14(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: CORRALES SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 39467 , F 76, S 8, H M 693100, I/A 15(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MINGO JORGE LUIS. Datos registrales. T 39467 , F 78, S 8, H M 693100, I/A 16 (31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: DONOSO REBUELTA JOSE LUIS. Datos registrales. T 39467 , F 78, S 8, H M 693100, I/A 17(31.10.19).

Nombramientos. Apoderado: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 39467 , F 79, S 8, H M 693100, I/A 18(31.10.19).

07 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: COLIO ABRIL PABLO;GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 39005 , F 173, S 8, H M693100, I/A 3 (30.09.19).

04 de Octubre de 2019
Nombramientos. Vicepresid.: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 39005 , F 173, S 8, H M 693100, I/A 2 (27.09.19).

04 de Julio de 2019
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.05.19. Objeto social: a) La compra, suscripci贸n; tenencia, permuta y venta de valoresmobiliarios nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediaci贸n. Se except煤an las actividades expresamentereservadas por la ley, a las instituciones de Inversi贸n Colectiva... Domicilio: AVDA CAMINO DE SANTIAGO 40 (MADRID). Capital:3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SL.Nombramientos. Consejero: ABOUMRAD GONZALEZ ALEJANDRO. Presidente: ABOUMRAD GONZALEZ ALEJANDRO.Consejero: COLIO ABRIL PABLO;MARTINEZ PARRA MIGUEL ANGEL;TAYLOR PAUL. Secretario: SANCHEZ DE VIVAR JIMENEZMARIA ISABEL. Datos registrales. T 39005 , F 170, S 8, H M 693100, I/A 1 (27.06.19).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n