Buscador CIF Logo

Actos BORME Felca Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Felca Sa

Actos BORME Felca Sa - A08409948

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Felca Sa con CIF A08409948

馃敊 Perfil de Felca Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Felca Sa

07 de Julio de 2021
Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 41263 , F 209, S 8, H B 34330, I/A 48(29.06.21).

Revocaciones. CONSEJERO: MOLINA RUBIO ROSER. VICEPRESIDEN: MOLINA RUBIO ROSER. CONSEJERO: ARNALVINYALS LUIS. PRESIDENTE: ARNAL VINYALS LUIS. CONSEJERO: MOLINA RUBIO MARIA ROSER. VICEPRESIDEN: MOLINARUBIO MARIA ROSER. CONSEJERO: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. Nombramientos. CONSEJERO: ARNAL VINYALSLUIS. PRESIDENTE: ARNAL VINYALS LUIS. CONSEJERO: MOLINA RUBIO MARIA ROSER. VICEPRESIDEN: MOLINA RUBIOMARIA ROSER. CONS.DEL.SOL: MOLINA RUBIO MARIA ROSER. CONSEJERO: ARNAL MOLINA MARC;ARNAL MOLINA SERGI.SE.TEC.NO CO: ACHA VILLAR JOSE LUIS. Datos registrales. T 41263 , F 209, S 8, H B 34330, I/A 47 (29.06.21).

09 de Junio de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FELCA UNITS SA. Datos registrales. T 41263 , F 208, S 8, H B 34330, I/A 46(29.05.20).

04 de Marzo de 2019
Revocaciones. APODERADO: BOSCH PEREZ SERGIO. Datos registrales. T 41263 , F 208, S 8, H B 34330, I/A 45 (22.02.19).

22 de Noviembre de 2018
Revocaciones. APODERADO: RAMOS PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41263 , F 207, S 8, H B 34330, I/A 44(13.11.18).

14 de Junio de 2017
Revocaciones. SECR.NO CONS: ACHA CONSULTORES SL. REPR.143 RRM: ACHA VILLAR JOSE LUIS. Nombramientos.CONSEJERO: ARNAL VINYALS LUIS. PRESIDENTE: ARNAL VINYALS LUIS. CONSEJERO: MOLINA RUBIO MARIA ROSER.VICEPRESIDEN: MOLINA RUBIO MARIA ROSER. CONSEJERO: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. SE.TEC.NO CO: ACHAVILLAR JOSE LUIS. Datos registrales. T 41263 , F 207, S 8, H B 34330, I/A 43 ( 2.06.17).

26 de Agosto de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: BALCELLS GARGALLO ISAAC. Datos registrales. T 41263 , F 206, S 8, H B 34330, I/A 42(18.08.16).

10 de Enero de 2014
Revocaciones. APODERADO: ARNAL MOLINA GERARD. CONSEJERO: ARNAL MOLINA GERARD. CONS. DELEG.: ARNALMOLINA GERARD. SECRETARIO: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. Nombramientos. VICEPRESIDEN: MOLINA RUBIOMARIA ROSER. SECR.NO CONS: ACHA CONSULTORES SL. REPR.143 RRM: ACHA VILLAR JOSE LUIS. Datos registrales. T41263 , F 206, S 8, H B 34330, I/A 41 ( 2.01.14).

05 de Noviembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MARIMON CONSULTORS I AUDITORS SLP. Datos registrales. T 41263 , F 206, S 8, H B34330, I/A 40 (25.10.13).

04 de Septiembre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 665.317,98 Euros. Desembolsado: 665.317,98 Euros. Resultante Suscrito: 1.499.994,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.499.994,00 Euros. Datos registrales. T 41263 , F 205, S 8, H B 34330, I/A 39 (28.08.13).

29 de Junio de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 83.176,02 Euros. Desembolsado: 83.176,02 Euros. Resultante Suscrito: 834.676,02 Euros.Resultante Desembolsado: 834.676,02 Euros. Cambio de objeto social. SE AMPLIA EN:FABRICACION,INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE CLIMATIZACION Y PRODUCTORES DEFRIO,CALOR Y AIRE ACONDICIONADO,ASI COMO DE INSTALACIONES DE GAS,AGUA Y DEMAS SUMINISTRADORES DEGASES, ETC. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CLIMA FELCA SA. Datos registrales. T 41263 , F 203, S 8, H B34330, I/A 38 (19.06.12).

07 de Diciembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: FRANCO ESTADELLA EDUARDO. Datos registrales. T 41263 , F 202, S 8, H B 34330, I/A 36(24.11.11).

Nombramientos. CONSEJERO: ARNAL VINYALS LUIS. PRESIDENTE: ARNAL VINYALS LUIS. CONSEJERO: ARNAL MOLINAGERARD. CONS. DELEG.: ARNAL MOLINA GERARD. CONSEJERO: MOLINA RUBIO ROSER. VICEPRESIDEN: MOLINA RUBIOROSER. CONSEJERO: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. SECRETARIO: GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL. Datos registrales.T 41263 , F 203, S 8, H B 34330, I/A 37 (24.11.11).

07 de Marzo de 2011
Nombramientos. APODERADO: RAMOS PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41263 , F 201, S 8, H B 34330, I/A 35

21 de Julio de 2010
Revocaciones. APODERADO: SERRA DARANAS JOSEP. Datos registrales. T 41263 , F 201, S 8, H B 34330, I/A 34 ( 9.07.10).

25 de Junio de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MARIMON CONSULTORS I AUDITORS SL. Datos registrales. T 41263 , F 201, S 8, H B 34330,I/A 33 (14.06.10).

22 de Junio de 2009
Nombramientos. APODERADO: SERRA DARANAS JOSEP. Datos registrales. T 22175 , F 158, S 8, H B 34330, I/A 32 ( 5.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n