Actos BORME de Felguera Montajes Y Mantenimiento Sa
01 de Octubre de 2012Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2914 , F 166, S 8, H AS 1092, I/A 76 (20.09.12).
23 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PAÑEDA DAVID;MARTINEZ PASTOR ANGEL. Datos registrales. T 2914 , F 166, S 8, HAS 1092, I/A 75 (10.05.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ PASTOR ANGEL;NIETO ARCONADA INES;LASA GOMEZ JAIME. Apo.Sol.: MARTINEZPASTOR ANGEL. Datos registrales. T 2914 , F 165, S 8, H AS 1092, I/A 73 (23.03.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: NIETO ARCONADA INES;LASA GOMEZ JAIME. Datos registrales. T 2914 , F 165, S 8, H AS 1092,I/A 74 (23.03.12).
17 de Enero de 2012Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ADA BYRON 90 - PARQUECIENTIFICO Y TECNOLOGICO. (GIJON). Datos registrales. T 2914 , F 165, S 8, H AS 1092, I/A 72 ( 4.01.12).
01 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: TORRES INCLAN JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2914 , F 164, S 8, H AS 1092, I/A 71 (22.08.11).
12 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: GUITARTE DELGADO FEDERICO. Datos registrales. T 2914 , F 164, S 8, H AS 1092, I/A 70 ( 1.07.11).
29 de Junio de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: CARCEDO HERRERO PEDRO. Datos registrales. T 2914 , F 164, S 8, H AS 1092, I/A 69 (16.06.11).
21 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: OUTEIRAL VIANA JUAN. Datos registrales. T 2914 , F 164, S 8, H AS 1092, I/A 68 ( 9.06.11).
16 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 2914 , F 163, S 8, H AS 1092, I/A 67 ( 3.05.11).
04 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MORTERA MORAN ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: HERRERO RODRIGUEZ JUANJOSE. Datos registrales. T 2914 , F 161, S 8, H AS 1092, I/A 60 (15.04.11).
Revocaciones. Apoderado: LASA GOMEZ JAIME;CARCEDO HERRERO PEDRO. Datos registrales. T 2914 , F 161, S 8, H AS1092, I/A 61 (15.04.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARCEDO HERRERO PEDRO;LOPEZ DURAN ALVARO;RODRIGUEZ CANSECO IGNACIO. Datosregistrales. T 2914 , F 162, S 8, H AS 1092, I/A 62 (15.04.11).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PAÑEDA DAVID. Datos registrales. T 2914 , F 162, S 8, H AS 1092, I/A 63 (15.04.11).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PASTOR ANGEL. Datos registrales. T 2914 , F 162, S 8, H AS 1092, I/A 64 (15.04.11).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA LUIS CANDIDO. Datos registrales. T 2914 , F 163, S 8, H AS 1092, I/A 65(15.04.11).
Nombramientos. Apoderado: BAUSELA SACHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 2914 , F 163, S 8, H AS 1092, I/A 66(15.04.11).
20 de Agosto de 2010Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SAN MIGUEL EDUARDO;MARTINEZ SAN MIGUEL EDUARDO. Datos registrales. T 2914 ,F 161, S 8, H AS 1092, I/A 58 (10.08.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: OUTEIRAL VIANA JUAN. Datos registrales. T 2914 , F 161, S 8, H AS 1092, I/A 59 (10.08.10).
18 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: CARCEDO HERRERO PEDRO. Datos registrales. T 2914 , F 160, S 8, H AS 1092, I/A 57 ( 8.06.10).
09 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CANAL CARLOS IGNACIO;FANO FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 2914 ,F 159, S 8, H AS 1092, I/A 55 (27.01.10).
Nombramientos. Apoderado: GUITARTE DELGADO FEDERICO. Datos registrales. T 2914 , F 160, S 8, H AS 1092, I/A 56(27.01.10).
03 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ RODRIGUEZ SAMPEDRO 56º (GIJON). Datos registrales. T 2914 , F 159, S 8, H AS 1092, I/A 54 (25.01.10).
29 de Septiembre de 2009Revocaciones. Adm. Unico: RUIZ CORNEJO JUAN CARLOS MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: MORTERA MORANANTONIO. Datos registrales. T 2914 , F 159, S 8, H AS 1092, I/A 53 (17.09.09).
10 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2914 , F 159, S 8, H AS 1092, I/A52 (28.07.09).
17 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ ACEBAL ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: RUIZ CORNEJO JUAN CARLOSMANUEL. Datos registrales. T 2914 , F 159, S 8, H AS 1092, I/A 51 ( 7.07.09).
16 de Marzo de 2009Reelecciones. Adm. Unico: MARTINEZ ACEBAL ANTONIO. Datos registrales. T 2914 , F 159, S 8, H AS 1092, I/A 50 ( 4.03.09).
27 de Enero de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES INCLAN JUAN CARLOS;DEL VALLE SUAREZ ANGEL ANTONIO. Datos registrales. T 2914 ,F 158, S 8, H AS 1092, I/A 49 ( 8.01.09).