Buscador CIF Logo

Actos BORME Felix Gonzalez Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Felix Gonzalez Sociedad Anonima

Actos BORME Felix Gonzalez Sociedad Anonima - A06000913

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Badajoz para Felix Gonzalez Sociedad Anonima con CIF A06000913

馃敊 Perfil de Felix Gonzalez Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Badajoz

Actos BORME de Felix Gonzalez Sociedad Anonima

20 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALFONSO MERA GOMEZ;FELIPE VICTORIANO CABALLERO GOMEZ;JUAN ANTONIO CERRATOLOZANO;LUIS JULIAN SANCHEZ GALLARDO;SERGIO GOMEZ CARMONA. Secretario: LUIS JULIAN SANCHEZ GALLARDO.Presidente: SERGIO GOMEZ CARMONA. Nombramientos. Consejero: ALFONSO MERA GOMEZ;JOSE-LUIS SANCHEZ-PORROGODOY;LUIS JULIAN SANCHEZ GALLARDO;FEDERICO ESTEBAN CERRATO;ALBERTO OLIVENZA GOMEZ. Presidente: JOSE-LUIS SANCHEZ-PORRO GODOY. Secretario: LUIS JULIAN SANCHEZ GALLARDO. Datos registrales. T 693 , F 223, S 8, H BA743, I/A 52 (13.12.23).

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: LAURA TAPIA FERNANDEZ. Datos registrales. T 693 , F 223, S 8, H BA 743, I/A 51 ( 4.10.22).

29 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: LUIS MIGUEL MARQUEZ DIAZ. Datos registrales. T 693 , F 222, S 8, H BA 743, I/A 50 (22.09.22).

11 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: LAURA TAPIA FERNANDEZ. Datos registrales. T 693 , F 222, S 8, H BA 743, I/A 49 ( 3.11.21).

13 de Octubre de 2021
Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones. Datos registrales. T 693 , F 221, S 8, H BA 743, I/A 48 ( 5.10.21).

01 de Septiembre de 2021
Modificaciones estatutarias. 10. Funcionamiento Junta General. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina webcorporativa: www.grupofelixgonzalez.es. Datos registrales. T 693 , F 221, S 8, H BA 743, I/A 47 (25.08.21).

18 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA ISABEL YECORA CABALLERO. Nombramientos. Consejero: FELIPE VICTORIANOCABALLERO GOMEZ. Datos registrales. T 693 , F 221, S 8, H BA 743, I/A 46 (11.02.20).

16 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANA MARIA PEDROSA BARRERO;FELIPE VICTORIANO CABALLERO GOMEZ;SANCHEZGALLARDO LUIS;MARIA ISABEL YECORA CABALLERO;GOMEZ CARMONA SERGIO. Presidente: GOMEZ CARMONA SERGIO.Secretario: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Nombramientos. Consejero: SERGIO GOMEZ CARMONA;MARIA ISABEL YECORACABALLERO;LUIS SANCHEZ GALLARDO;ALFONSO MERA GOMEZ;JUAN ANTONIO CERRATO LOZANO. Presidente: SERGIOGOMEZ CARMONA. Secretario: LUIS SANCHEZ GALLARDO. Datos registrales. T 671 , F 180, S 8, H BA 743, I/A 45 ( 9.11.18).

06 de Junio de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: JOSE MARCIAL GONZALEZ GONZALEZ. Revocaciones. Auditor: JUANANTONIO MONTERREY MAYORAL. Aud.Supl.: BEATRIZ GIL SANCHEZ. Datos registrales. T 671 , F 180, S 8, H BA 743, I/A 44(30.05.18).

02 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: MARIA ISABEL YECORA CABALLERO. Datos registrales. T 671 , F 179, S 8, H BA 743, I/A 43(26.01.18).

11 de Diciembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los Estatutos : 2. Objeto. Cambio de objeto social. Art铆culo 2.- Objeto social: La sociedadtiene por objeto social:a. La pre staci贸n de servicios de administraci贸n, asistencia t茅cnica, gesti贸n y control de empresas y negocios,as铆 como a sus sociedades dependientes, como actividad principal.b. La suscripci贸n, adquisici贸n derivativa, tenencia, disfr. Escisi贸nparcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE DON BENITO S. Datosregistrales. T 281 , F 24, S 8, H BA 743, I/A 42 (30.11.17).

18 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CESAREO PAJARES YEDRO. Datos registrales. T 281 , F 24, S 8, H BA 743, I/A 41 (10.10.17).

11 de Agosto de 2017
Nombramientos. Aud.Supl.: BEATRIZ GIL SANCHEZ. Reelecciones. Auditor: JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL. Datosregistrales. T 281 , F 23, S 8, H BA 743, I/A 40 ( 4.08.17).

29 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: MONTERREY MAYORAL JUAN ANTONIO. Aud.Supl.: GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARCIAL. Datosregistrales. T 281 , F 23, S 8, H BA 743, I/A 39 (21.07.16).

24 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE MERA CAZALET DE HAUT GUILLERMO. Presidente: DE MERA CAZALET DE HAUTGUILLERMO. Consejero: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Secretario: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Consejero: MU脩OZ GARCIAMANUEL;GOMEZ CARMONA SERGIO;YECORA CABALLERO MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero: PEDROSA BARREROANA MARIA;GOMEZ CARMONA SERGIO. Presidente: GOMEZ CARMONA SERGIO. Consejero: YECORA CABALLERO MARIAISABEL;SANCHEZ GALLARDO LUIS;CABALLERO GOMEZ FELIPE. Secretario: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Datos registrales. T281 , F 23, S 8, H BA 743, I/A 38 (10.12.13).

06 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Auditor: MONTERREY MAYORAL JUAN ANTONIO. Reelecciones. Auditor: MONTERREY MAYORAL JUANANTONIO. Aud.Supl.: GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARCIAL. Datos registrales. T 281 , F 22, S 8, H BA 743, I/A 37 (30.05.13).

16 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apoderado: CABALLERO CERRATO SANTIAGO. Datos registrales. T 281 , F 22, S 8, H BA 743, I/A 35 ( 7.02.11).

Ceses/Dimisiones. Gerente: BLAZQUEZ BRAVO BALDOMERO. Datos registrales. T 281 , F 22, S 8, H BA 743, I/A 36 ( 7.02.11).

07 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Auditor: MONTERREY MAYORAL JUAN ANTONIO. Aud.Supl.: GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARCIAL. Datosregistrales. T 281 , F 22, S 8, H BA 743, I/A 34 (26.11.09).

06 de Julio de 2009
Fe de erratas: SE ANULA Y SE ENVIA NUEVO ACTO RECTIFICADO. Datos registrales. T 281 , F 21, S 8, H BA 743, I/ANota/(18.05.09).

Nombramientos. Auditor: MONTERREY MAYORAL JUAN ANTONIO. Otros conceptos: Nombrado Auditor conforme al Art铆culo350 RRM, DON JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL para auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008, seg煤nconsta en los antecedentes del expediente 337 del Legajo de Expertos y Auditores de este Registro. Badajoz, 25 de Junio de 2009.Datos registrales. T 281 , F 21, S 8, H BA 743, I/ANota/ (25.06.09).

29 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ PORRO PAREJO ANTONIO;CABALLERO CERRATO SANTIAGO. Presidente: SANCHEZPORRO PAREJO ANTONIO. Secretario: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Consejero: MU脩OZ GARCIA MANUEL;DE MERA CAZALETDE HAUT GUILLERMO;SANCHEZ GALLARDO LUIS. Nombramientos. Consejero: DE MERA CAZALET DE HAUT GUILLERMO.Presidente: DE MERA CAZALET DE HAUT GUILLERMO. Consejero: SANCHEZ GALLARDO LUIS. Secretario: SANCHEZGALLARDO LUIS. Consejero: MU脩OZ GARCIA MANUEL;GOMEZ CARMONA SERGIO;YECORA CABALLERO MARIA ISABEL.Datos registrales. T 281 , F 21, S 8, H BA 743, I/A 33 (20.05.09).

27 de Mayo de 2009
Otros conceptos: Nombrado Auditor conforme al Art铆culo 350 RRM, DON JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL para auditar lascuentas anuales del ejercicio 2007, seg煤n consta en los antecedentes del expediente 337 del Legajo de Expertos y Auditores de esteRegistro.Badajoz, 18 de Mayo de 2009. Datos registrales. T 281 , F 21, S 8, H BA 743, I/ANota/ (18.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n