Buscador CIF Logo

Actos BORME Fender Iberica Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fender Iberica Sl

Actos BORME Fender Iberica Sl - B83164079

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fender Iberica Sl con CIF B83164079

🔙 Perfil de Fender Iberica Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fender Iberica Sl

15 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO. Presidente: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO. Consejero:MEIER KARL LAURENCE. Revocaciones. Apoderado: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO;BARRAGAN SANCHEZFERNANDO;BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO;SULLIVAN STEVEN JOHN;BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO.Nombramientos. Consejero: DARROODI AARASCH. Presidente: CUNNAH LIAM. Cambio de domicilio social. C/ PRINCESA 223º (MADRID). Datos registrales. T 37539 , F 15, S 8, H M 293156, I/A 17 ( 8.06.21).

25 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: CUNNAH LIAM. Datos registrales. T 37539 , F 14, S 8, H M 293156, I/A 16 (18.02.20).

14 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DARROODI AARASCH. Nombramientos. Consejero: MEIER KARL LAURENCE;CUNNAH LIAM.Datos registrales. T 37539 , F 14, S 8, H M 293156, I/A 15 ( 7.11.19).

24 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: ESTRELLA PEREZ SEOANE. Datos registrales. T 17117 , F 48, S 8, H M 293156, I/A 14 (17.04.18).

26 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN VLEET MARK DAVID. Nombramientos. Consejero: DARROODI AARASCH. Datosregistrales. T 17117 , F 48, S 8, H M 293156, I/A 13 (18.07.17).

24 de Marzo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ PRINCESA 22 4º - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 17117 , F 48, S 8, H M 293156, I/A12 (16.03.17).

01 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apoderado: CODY ELIZABETH ANGELINA;CODY ELIZABETH ANGELINA. Datos registrales. T 17117 , F 48, S 8,H M 293156, I/A 11 (23.09.15).

06 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: THOMAS LARRY E. Nombramientos. Consejero: VAN VLEET MARK DAVID. Reelecciones.VsecrNoConsj: PEREZ SEOANE ESTRELLA. Secretario: MCAULEY GERARD. Presidente: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO.Datos registrales. T 17117 , F 47, S 8, H M 293156, I/A 10 (29.10.14).

31 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAISON GORDON. Con.Delegado: RAISON GORDON. Presidente: RAISON GORDON.Nombramientos. Consejero: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO. Presidente: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO.Modificaciones estatutarias. 24. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 17117 , F 47, S 8, H M 293156, I/A 9(23.10.13).

21 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: SULLIVAN STEVEN JOHN;MCAULEY GERALD;BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO;CODYELIZABETH ANGELINA;ESTRELLA PEREZ SEOANE. Datos registrales. T 17117 , F 46, S 8, H M 293156, I/A 8 (12.03.13).

09 de Mayo de 2012
Nombramientos. Apoderado: BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 17117 , F 46, S 8, H M 293156, I/A 7(25.04.12).

24 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDELLO WILLIAM LOUIS;GOLD JON. Revocaciones. Apoderado: GOLD JON.Nombramientos. Consejero: THOMAS LARRY E. Datos registrales. T 17117 , F 46, S 8, H M 293156, I/A 6 (14.02.11).

18 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: GOLD JON;MCAULEY GERALD;BARRAGAN SANCHEZ FERNANDO;CODY ELIZABETHANGELINA;RAISON GORDON LEONARD THOMAS. Datos registrales. T 17117 , F 45, S 8, H M 293156, I/A 5 ( 6.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información