Actos BORME de Ferdam Sa
29 de Abril de 2021Extinci贸n. Datos registrales. T 33710 , F 215, S 8, H M 20043, I/A 24 (22.04.21).
18 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DE DAMAS MULLER MARIA ANGUSTIAS;FERNANDEZ DE SANTAELLA Y GOZALVEZJAVIER;FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMAS ANGUSTIAS. Presidente: FERNANDEZ DE SANTAELLA Y GOZALVEZ JAVIER.Secretario: FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMAS ANGUSTIAS. Con.Delegado: FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMASANGUSTIAS. Nombramientos. Adm. Unico: ESCRIBANO LOPEZ-JURADO VICTOR. Modificaciones estatutarias. 10.Administraci贸n y Representacion.-. 16. Administraci贸n y Representacion.-. 17. Administraci贸n y Representacion.-. 18. Administraci贸n yRepresentacion.-. 23. Administraci贸n y Representacion.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1037 , F 136, S 8, H M 20043, I/A 22 ( 3.08.15).
25 de Agosto de 2011Cambio de domicilio social. C/ DIEGO DE LEON NUMERO 30, 3潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 1037 , F 136, S 8,H M 20043, I/A 21 (16.08.11).
23 de Junio de 2010Reelecciones. Consejero: DE DAMAS MULLER MARIA ANGUSTIAS;FERNANDEZ DE SANTAELLA Y GOZALVEZJAVIER;FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMAS ANGUSTIAS. Secretario: FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMASANGUSTIAS. Con.Delegado: FERNANDEZ DE SANTAELLA DE DAMAS ANGUSTIAS. Presidente: FERNANDEZ DE SANTAELLA YGOZALVEZ JAVIER. Datos registrales. T 1037 , F 136, S 8, H M 20043, I/A 20 (11.06.10).