Buscador CIF Logo

Actos BORME Fergil Auto Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fergil Auto Sl

Actos BORME Fergil Auto Sl - B27416064

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Fergil Auto Sl con CIF B27416064

馃敊 Perfil de Fergil Auto Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lugo

Actos BORME de Fergil Auto Sl

20 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 553 , F 151, S 8, H LU 14027, I/A 32 (6.10.23).

21 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 553 , F 151, S 8, H LU 14027, I/A 31(14.12.22).

06 de Julio de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL SANTOS RUBEN;PEREZ OTERO JOSE MARIA;ESTEVEZ ALONSO JORGE;FREIREVILLEGAS RAUL;GARCIA VI脩A MARIA;FERNANDEZ-VIAL GONZALEZ-BARBA ENRIQUE;FERNANDEZ CANDAUALVARO;BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 496 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 29 (22.06.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD. Nombramientos. Consejero: GILSANTOS 2022 SL.Datos registrales. T 496 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 30 (27.06.22).

29 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 496 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 26(21.10.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: LOMBARDERO ALVAREZ JOSE. Datos registrales. T 496 , F 170, S 8, H LU 14027, I/A 27 (22.10.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: MOSQUERA LOPEZ OSCAR;VARELA ARMAS JUAN. Datos registrales. T 496 , F 172, S 8, H LU14027, I/A 28 (22.10.21).

23 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: FEVIROM INVERSIONES SL. Presidente: FEVIROM INVERSIONES SL. Co.De.Ma.So: FEVIROMINVERSIONES SL. Secretario: BENITEZ RINCON DAVID. Consejero: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Co.De.Ma.So: FERNANDEZCANDAU ALVARO. Consejero: FERNANDEZ-VIAL ROMAN ENRIQUE. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ-VIAL ROMAN ENRIQUE.Consejero: MONTES AGUSTI ROSINA ANTONIA;VAZQUEZ ESPINOSA MARGARITA;SANTOS REDONDO ROSA MARIASOLEDAD;RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL.Consejero: FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA. Nombramientos. Consejero:FEVIROM INVERSIONES SL;FERNANDEZ-VIAL ROMAN ENRIQUE;FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA;FERNANDEZ CANDAUALVARO;RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL;MONTES AGUSTI ROSINA ANTONIA;VAZQUEZ ESPINOSAMARGARITA;SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD. Presidente: FEVIROM INVERSIONES SL. Secretario: BENITEZRINCON DAVID. Co.De.Ma.So: FEVIROM INVERSIONES SL;FERNANDEZ-VIAL ROMAN ENRIQUE;FERNANDEZ VIAL ROMANBORJA;FERNANDEZ CANDAU ALVARO;RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL. Datos registrales. T 496 , F 172, S 8, HLU 14027, I/A 25 ( 9.12.20).

16 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 496 , F 171, S 8, H LU 14027, I/A 24 (6.11.20).

28 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 496 , F 171, S 8, H LU 14027, I/A 23(18.10.19).

15 de Febrero de 2019
Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA. Datosregistrales. T 496 , F 171, S 8, H LU 14027, I/A 22 ( 5.02.19).

24 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ VALCARCEL RAUL;SANTOS ALVARI脩O SEGUNDO;LOMBARDERO ALVAREZ JOSE;FREIXOCARBALLO LUIS;VARELA ROIS MARCOS;RODRIGUEZ VAZQUEZ MARCOS;FERREIRO FONTAO FERNANDO;CARBALLOSABALADO PABLO;RODRIGUEZ HORTAS DANIEL. Datos registrales. T 496 , F 170, S 8, H LU 14027, I/A 21 (13.12.18).

10 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ AYALA MORENO SANTAMARIA MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero:RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ ARGUESO Y PEREZ DE AYALA SL. Datosregistrales. T 496 , F 170, S 8, H LU 14027, I/A 20 (28.11.18).

12 de Febrero de 2018
Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: GIL SANTOS RUBEN;PEREZ OTERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 496 , F 170, S8, H LU 14027, I/A 19 (26.01.18).

03 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL SANTOS RUBEN;PEREZ OTERO JOSE MARIA;ESTEVEZ ALONSO JORGE;FREIREVILLEGAS RAUL;VAZQUEZ LOPEZ MARTA;ENRIQUE FERNANDEZ VIAL GONZALEZ BARBA;FERNANDEZ CANDAUALVARO;BENITEZ RINCON DAVID. Datos registrales. T 496 , F 169, S 8, H LU 14027, I/A 18 (24.10.17).

14 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA. Datos registrales. T 496 , F 269, S 8, H LU 14027, I/A 17 (7.07.17).

16 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ OTERO JOSE MARIA;LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON. Datos registrales. T 449 , F 173,S 8, H LU 14027, I/A 16 ( 8.03.17).

05 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 449 , F 173, S 8, H LU 14027, I/A 15(26.08.16).

22 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ENFEVI INVERSIONES SL;FEVIROM INVERSIONES SL;PEREZ AYALA MORENO SANTAMARIAMARIA TERESA;VAZQUEZ ESPINOSA MARGARITA;SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD;FERVILTA SL;FERNANDEZCANDAU ALVARO;FERNANDO SOLIS MARTINEZ CAMPOS. Presidente: FEVIROM INVERSIONES SL. Vicepresid.: FERVILTA SL.Secretario: BENITEZ RINCON DAVID. Vicesecret.: JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ DE AYALA. Co.De.Ma.So: FERVILTASL;FEVIROM INVERSIONES SL;FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Nombramientos. Consejero: FEVIROM INVERSIONES SL.Presidente: FEVIROM INVERSIONES SL. Co.De.Ma.So: FEVIROM INVERSIONES SL. Secretario: BENITEZ RINCON DAVID.Consejero: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Consejero: FERNANDEZ-VIALROMAN ENRIQUE. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ-VIAL ROMAN ENRIQUE. Consejero: MONTES AGUSTI ROSINAANTONIA;FERNANDEZ VIAL ROMAN BORJA;VAZQUEZ ESPINOSA MARGARITA;PEREZ AYALA MORENO SANTAMARIA MARIATERESA;SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD. Modificaciones estatutarias. La Junta General tendr谩 lugar en la localidaddonde la Sociedad tenga su domicilio social o en la Avda. Reino Unido, 11, 3潞 Planta, Edificio Indotorre (Sevilla) a elecci贸n requeridadel Organo de Administraci贸n. Los socios reunidos en la Junta General, decidir谩n por la mayor铆a legal en los asuntos . Si laAdministraci贸n fuese administrada por un Administrador Unico estar谩 integrada por los socios y el Administrador Unico. Si laAdministraci贸n fuese administrada por un Consejo de Administraci贸n estar谩 integrado por el n煤mero de Consejeros que, en cadamomento, acuerde la Junta General, y que. Datos registrales. T 449 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 14 (12.02.16).

22 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: FERNANDO SOLIS MARTINEZ CAMPOS. Consejero: ANAJOSEGON INVERSIONES SL. Datosregistrales. T 449 , F 172, S 8, H LU 14027, I/A 13 (12.05.15).

21 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 449 , F 171, S 8, H LU 14027,I/A 12 (14.10.14).

07 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: GIL SANTOS DAVID;PEREZ OTERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 449 , F 171, S 8, H LU14027, I/A 11 (27.06.14).

15 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA. Nombramientos. Consejero: ANAJOSEGONINVERSIONES SL. Datos registrales. T 449 , F 171, S 8, H LU 14027, I/A 10 ( 8.01.14).

17 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 449 , F 170, S 8, H LU 14027,I/A 9 (10.10.13).

05 de Septiembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: GIL SANTOS RUBEN. Datos registrales. T 449 , F 170, S 8, H LU 14027, I/A 7 (27.08.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL SANTOS RUBEN;PEREZ OTERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 449 , F 170, S 8, H LU14027, I/A 8 (27.08.13).

26 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MI脩O SL. Nombramientos. Consejero: ENFEVIINVERSIONES SL;EFDEZ BIENES SL;PEREZ AYALA MORENO SANTAMARIA MARIA TERESA;VAZQUEZ ESPINOSAMARGARITA;SANTOS REDONDO ROSA MARIA SOLEDAD;FERVILTA SL;AMBROSIO MARCOS MARIA AMAYA;FERNANDEZCANDAU ALVARO;FERNANDO SOLIS MARTINEZ CAMPOS. Presidente: EFDEZ BIENES SL. Vicepresid.: FERVILTA SL. Secretario:BENITEZ RINCON DAVID. Vicesecret.: JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ DE AYALA. Co.De.Ma.So: FERVILTA SL;EFDEZBIENES SL;FERNANDO SOLIS MARTINEZ CAMPOS;FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 428 , F 109, S 8, H LU 14027, I/A 4(15.02.13).

Modificaciones estatutarias. cargo de Consejero ser谩 gratuito y no remunerado.. Datos registrales. T 428 , F 110, S 8, H LU14027, I/A 5 (15.02.13).

Nombramientos. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 428 , F 110, S 8, H LU14027, I/A 6 (15.02.13).

09 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANDAU ALVARO. Datos registrales. T 428 , F 108, S 8, H LU 14027, I/A 3 (22.07.11).

15 de Marzo de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.01.11. Objeto social: La Organizaci贸n y explotaci贸n de toda clase de industrias ynegocios que sean l铆citos con arreglo a las Leyes y que guarden relaci贸n con la representaci贸n, distribuci贸n, transformaci贸n y venta deveh铆culos y motores industriales y comerciafizaci贸n de los mismos, incluso sus reparaciones y recamblos;. Domicilio: CTRA DE LACORU脩A 143 (LUGO). Capital: 450.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DISTRIBUIDORA YTRANSFORMADORA DEL MI脩O SL. Nombramientos. Adm. Unico: DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MI脩O SL.Datos registrales. T 428 , F 107, S 8, H LU 14027, I/A 1 ( 2.03.11).

Nombramientos. Apoderado: GIL SANTOS RUBEN. Datos registrales. T 428 , F 107, S 8, H LU 14027, I/A 2 ( 2.03.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n