Actos BORME de Fermax Holding Investment Sociedad Limitada
21 de Diciembre de 2023Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 224, S 8, H V 141191, I/A 23 (14.12.23).
30 de Octubre de 2023Otros conceptos: Eliminacion de las dos clases de participaciones sociales, con las consiguientes modificación del articulo 5º yderogacion del articulo 29º del los estatutos sociales. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GLOBAL TRACIA SL. Datosregistrales. T 9331, L 6613, F 222, S 8, H V 141191, I/A 22 (23.10.23).
10 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: PALACIO CHAVAGNAT JEREMY. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 222, S 8, H V 141191, I/A 21 (3.10.23).
11 de Agosto de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 222, S 8, H V 141191, I/A 20 ( 4.08.23).
23 de Mayo de 2023Declaración de unipersonalidad. Socio único: GLOBAL TRACIA SL. Nombramientos. Consejero: HARA BENJAMIN OLIVIERVICTOR. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 175, S 8, H V 141191, I/A 17 (16.05.23).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORANTE ROBERTO VICENTE. Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORANTEROBERTO VICENTE. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 175, S 8, H V 141191, I/A 19 (16.05.23).
09 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCONSERGIO;RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Secretario: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Vicesecret.: MAESTRE AZCON SERGIO.Cons.Del.Sol: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON SERGIO. Presidente: MAESTRE AZCON JOSEFERNANDO. Consejero: GONZALEZ BELTRAN FLORENCIO;J. F. SEBASTIAN HOLDING SOCIEDAD LIMITADA. Pres.Honorif:MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN GARCIA ANGEL. VsecrNoConsj: LUJAMBIOLLAMAS JULIO. Consejero: PALACIO CHAVAGNAT JEREMY;CARO GARCIA FRANCISCO;WHITLEY SL;EISLEBEN SL. Presidente:PALACIO CHAVAGNAT JEREMY. Vicepresid.: CARO GARCIA FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo8º de los estatutos sociales. Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales. Modificación del artículo 25º de los estatutossociales. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Eliminado el artículo 26-bis de los estatutos sociales. Modificación delartículo 29º de los estatutos sociales. Renumerados los actuales artículos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º y 34º de los estatutos sociales quepasan a ser respectivamente los artículos 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º. Otros conceptos: JOSE MARIA MUÑOZ DOMINGUEZ hasido designado persona física representante de la consejera WHITLEY SL, y JOSE MANUEL DE BARTOLOME PALOMO de laconsejera EISLEBEN SL Creación de dos clases de participaciones sociales, Clase A y Clase B. Datos registrales. T 9331, L 6613, F171, S 8, H V 141191, I/A 14 (28.04.23).
Nombramientos. Con.Delegado: PALACIO CHAVAGNAT JEREMY. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 174, S 8, H V 141191, I/A15 (28.04.23).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 174, S 8, H V 141191, I/A 16(28.04.23).
02 de Marzo de 2023Nombramientos. Aud.C.Con.: CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 171, S 8, H V141191, I/A 13 (23.02.23).
14 de Enero de 2020Reelecciones. Aud.C.Con.: CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 171, S 8, H V141191, I/A 12 ( 7.01.20).
14 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Vicepresid.: SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: J. F. SEBASTIAN HOLDING SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Queda designado como persona físicarepresentante de la Sociedad designada como consejera "J.F. SEBASTIAN HOLDING, SL", su Consejero Delegado solidario, D. JUANFRANCISCO SEBASTIAN, con NIE X0342569F. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 171, S 8, H V 141191, I/A 11 ( 6.11.18).
11 de Noviembre de 2016Reelecciones. Aud.C.Con.: CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 171, S 8, H V141191, I/A 10 ( 3.11.16).
24 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO.Nombramientos. Presidente: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO. Pres.Honorif: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO.Modificaciones estatutarias. Adicionado un nuevo artículo de los Estatutos Sociales con el número 26BIS.. Datos registrales. T9331, L 6613, F 170, S 8, H V 141191, I/A 8 (17.05.16).
Nombramientos. Consejero: GONZALEZ BELTRAN FLORENCIO. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 171, S 8, H V 141191, I/A 9(17.05.16).
13 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: PALACIO CHAVAGNAT JEREMY. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 168, S 8, H V 141191, I/A 6 (6.04.16).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORANTE ROBERTO VICENTE. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 169, S 8, H V141191, I/A 7 ( 6.04.16).
05 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON SERGIO;RODRIGUEZ LUISSERGIO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;ABAD MELGAR JOSE JAVIER;SEBASTIAN JUANFRANCISCO. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Vicepresid.: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO. Secretario:ABAD MELGAR JOSE JAVIER. Vicesecret.: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Con.Delegado: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO.Nombramientos. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;SEBASTIAN JUANFRANCISCO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON SERGIO;RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Presidente: MAESTREMARTINEZ JOSE FERNANDO. Vicepresid.: SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Secretario: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Vicesecret.:MAESTRE AZCON SERGIO. Cons.Del.Sol: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON SERGIO. Datos registrales.T 9331, L 6613, F 168, S 8, H V 141191, I/A 5 (29.07.15).
06 de Febrero de 2014Nombramientos. Aud.C.Con.: ACR BGV AUDITORES SL. Datos registrales. T 9331, L 6613, F 168, S 8, H V 141191, I/A 4(30.01.14).
15 de Julio de 2011Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 9250, L 6533, F 171, S 8, H V 141191, I/A 3 (6.07.11).
21 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: GIL GINESTAR MARIA MONICA;RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Datos registrales. T 9250, L 6533, F170, S 8, H V 141191, I/A 2 (12.01.11).
14 de Diciembre de 2010Constitución. Comienzo de operaciones: 23.11.10. Objeto social: El objeto social lo constituye: 1. a - El comercio inmobiliario engeneral. b - La explotación del negocio arrendaticio de inmuebles -excepto elarrendamiento financiero tanto para usos industrialescomo no industrialesy cualesquiera otros y la prestación de los servicios a ello vinculados. Domicilio: AVDA TRES CRUCES 133(VALENCIA). Capital: 37.406.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTREAZCON SERGIO;RODRIGUEZ LUIS SERGIO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;ABAD MELGARJOSE JAVIER;SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Vicepresid.: MAESTREAZCON JOSE FERNANDO. Secretario: ABAD MELGAR JOSE JAVIER. Vicesecret.: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Con.Delegado:MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 9250, L 6533, F 165, S 8, H V 141191, I/A 1 ( 1.12.10).