Actos BORME de Ferpi Transportes Y Obras Sa
22 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: LOPEZ REGUEIRO JOSE LUIS;LOPEZ REGUEIRO JOSE LUIS;LOPEZ REGUEIRO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 26248 , F 85, S 8, H M 472980, I/A 39 (15.12.22).
22 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 26248 , F 85, S 8, H M 472980,I/A 38 (15.12.21).
03 de Noviembre de 2021Reelecciones. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 26248 , F 84, S 8, H M 472980, I/A 37(26.10.21).
18 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ASENJO CANEDO ARMANDO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 36陋 la revocaci贸n delpoder de ASENJO CANEDO ARMANDO. Datos registrales. T 26248 , F 84, S 8, H M 472980, I/A 36 (17.07.20).
24 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ TOMAS;GONZALEZ DAVILA EDUARDO. Apo.Man.Soli: PEREZ DIAZJHONATAN;MERA FERNANDEZ ALFONSO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Otros conceptos: Revocados los podeeresconferidos a Don Jyan Carlos Torre Garc铆a. Datos registrales. T 26248 , F 84, S 8, H M 472980, I/A 36 (17.07.20).
09 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DIAZ JHONATAN;MERA FERNANDEZ ALFONSO;SUAREZ CASTA脩ON FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 26248 , F 83, S 8, H M 472980, I/A 35 ( 2.03.20).
19 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: TAMARGO RODRIGUEZ JOSE. Datos registrales. T 26248 , F 83, S 8, H M 472980, I/A 34 (12.02.20).
16 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.272,00 Euros. Desembolsado: 9.272,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.585.926,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.585.926,00 Euros. Datos registrales. T 26248 , F 83, S 8, H M 472980, I/A 33 ( 5.12.19).
03 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: TAMARGO RODRIGUEZ JOSE;MERA FERNANDEZ ALFONSO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 26248 , F 83, S 8, H M 472980, I/A 32 (26.11.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ DIAZ JHONATAN;MERA FERNANDEZ ALFONSO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE.Datos registrales. T 26248 , F 82, S 8, H M 472980, I/A 31 (22.10.19).
03 de Septiembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 91.012,00 Euros. Desembolsado: 91.012,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.576.654,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.576.654,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 26248 , F 81, S 8, H M 472980, I/A 30 (27.08.19).
28 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 26248 , F 81, S 8, H M 472980,I/A 29 (21.02.19).
26 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER. Apoderado: PRIETO ORALLO JOSE MANUEL;RUBIO DIAZPABLO;LORENZANA FERNANDEZ JOSE FERNANDO;HERNANDEZ CARRILLERO CARLOS;YRAZUSTA DOUSSINAGUEIGNACIO;DIEZ ARIAS MANUEL. Apo.Sol.: PEREZ ARANGO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 26248 , F 81, S 8, H M 472980,I/A 28 (19.07.17).
01 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLE GONZALEZ LUIS ALBERTO;TAMARGO RODRIGUEZ JOSE;MERA FERNANDEZ ALFONSO.Datos registrales. T 26248 , F 80, S 8, H M 472980, I/A 27 (25.01.17).
22 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: TAMARGO RODRIGUEZ JOSE;MERA FERNANDEZ ALFONSO;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 26248 , F 79, S 8, H M 472980, I/A 26 (14.12.16).
23 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AGUADO SANTIAGO JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 26248 , F 79, S 8, H M 472980, I/A 25 (16.11.16).
01 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 26248 , F 79, S 8, H M 472980,I/A 24 (20.08.15).
19 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 26248 , F 79, S 8, H M 472980, I/A 23 (11.12.14).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: CORREIA GARRIDO JOAQUIN. Datos registrales. T 26248 , F 78, S 8, H M 472980, I/A 22 (8.07.14).
14 de Octubre de 2013Reelecciones. Adm. Unico: AGUADO SANTIAGO JUAN JOSE. Datos registrales. T 26248 , F 78, S 8, H M 472980, I/A 21 (4.10.13).
17 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: PASCUAL GEFAELL BORJA. Datos registrales. T 26248 , F 78, S 8, H M 472980, I/A 20 ( 9.07.13).
26 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO GAZTELUMENDI MIGUEL ANGEL;ALVAREZ GONZALEZ ANGEL;FERNANDEZ ALVAREZJOSE;PILLO VALES JOSE MARIA;FERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER. Apoderado: RODRIGUEZ LANZA JESUS;RODRIGUEZLANZA JESUS;RODRIGUEZ LANZA JESUS;FERNANDEZ ALVAREZ JOSE;PILLO VALES JOSE MARIA;FERNANDEZ ALVAREZJOSE;PILLO VALES JOSE MARIA. Datos registrales. T 26248 , F 77, S 8, H M 472980, I/A 19 (18.02.13).
20 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: TORRE GARCIA JUAN CARLOS. Apo.Sol.: TORRE GARCIA JUAN-CARLOS. Datos registrales. T26248 , F 77, S 8, H M 472980, I/A 18 (12.12.12).
25 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 26248 , F 77, S 8, H M 472980,I/A 17 (14.09.12).
22 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: TORRE GARCIA JUAN-CARLOS;ASENJO CANEDO ARMANDO. Datos registrales. T 26248 , F 75, S8, H M 472980, I/A 13 (13.06.12).
Revocaciones. Apo.Manc.: BAYON VALLADARES FELIX;BARRO FERNANDEZ ANTONIO JULIO;CALLE GONZALEZ LUISALBERTO;DIAZ ARAUJO JUAN MANUEL. Apoderado: BAYON VALLADARES FELIX. Apo.Sol.: BARRO FERNANDEZ ANTONIOJULIO;DIAZ ARAUJO JUAN MANUEL. Apo.Manc.: BARRO FERNANDEZ ANTONIO JULIO. Apo.Sol.: CALLE GONZALEZ LUISALBERTO. Apo.Manc.: DIAZ ARAUJO JUAN MANUEL;BAYON VALLADARES FELIX;CALLE GONZALEZ LUIS ALBERTO. Apo.Sol.:BAYON VALLADARES FELIX. Apoderado: GARCIA ENTRIALGO ANGEL;BAYON VALLADARES FELIX;DIAZ ARAUJO JUANMANUEL. Datos registrales. T 26248 , F 75, S 8, H M 472980, I/A 14 (13.06.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALLE GONZALEZ LUIS ALBERTO;TAMARGO RODRIGUEZ JOSE;MERA FERNANDEZALFONSO. Datos registrales. T 26248 , F 75, S 8, H M 472980, I/A 15 (13.06.12).
Nombramientos. Apoderado: MERA FERNANDEZ ALFONSO. Datos registrales. T 26248 , F 76, S 8, H M 472980, I/A 16(13.06.12).
10 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: PASCUAL GEFAELL BORJA. Datos registrales. T 26248 , F 74, S 8, H M 472980, I/A 12 ( 1.02.12).
30 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 147.010,00 Euros. Desembolsado: 147.010,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.485.642,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.485.642,00 Euros. Datos registrales. T 26248 , F 74, S 8, H M 472980, I/A 11 (17.06.11).
07 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.649,00 Euros. Desembolsado: 6.649,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.338.632,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.338.632,00 Euros. Datos registrales. T 26248 , F 73, S 8, H M 472980, I/A 10 (26.01.11).
04 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: TAMARGO RODRIGUEZ JOSE. Datos registrales. T 26248 , F 73, S 8, H M 472980, I/A 9 (22.09.10).
11 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: GARCIA ENTRIALGO ANGEL. Datos registrales. T 26248 , F 72, S 8, H M 472980, I/A 8 (28.12.09).
31 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: GARCIA ENTRIALGO ANGEL;BAYON VALLADARES FELIX;DIAZ ARAUJO JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 26248 , F 72, S 8, H M 472980, I/A 7 (18.12.09).
03 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SL. Datos registrales. T 26248 , F 72, S 8, H M 472980, I/A 6 (24.11.09).
14 de Julio de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 59.414,00 Euros. Desembolsado: 59.414,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.331.983,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.331.983,00 Euros. Datos registrales. T 26248 , F 71, S 8, H M 472980, I/A 5 ( 2.07.09).
19 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 26248 , F 70, S 8, H M 472980, I/A 3 ( 8.06.09).
Nombramientos. Apoderado: DIEZ ARIAS MANUEL. Datos registrales. T 26248 , F 71, S 8, H M 472980, I/A 4 ( 9.06.09).
16 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: YRAZUSTA DOUSSINAGUE IGNACIO;HERNANDEZ FUENTES MARIA DE LOS ANGELES;ALONSOVERDURAS LUIS. Datos registrales. T 26248 , F 69, S 8, H M 472980, I/A 3 ( 4.02.09).