Actos BORME de Ferrandara Sl
28 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRANDIZ ARA MARIA ELENA. Datos registrales. T 5783, L 3090, F 31, S 8, H V 54176, I/A 12(21.04.22).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ FERRANDIZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 5783, L 3090, F 31, S 8, H V 54176, I/A 13(21.04.22).
01 de Diciembre de 2020Otros conceptos: Se modifican los artículos 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 22 y 23 de los Estatutos Sociales, con el objetivode configurar estatutariamente el ejercicio frente a la sociedad de los derechos de los socios. Datos registrales. T 5783, L 3090, F 31,S 8, H V 54176, I/A 11 (24.11.20).
25 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ DEL MAR 34 1 2 (VALENCIA). Datos registrales. T 5783, L 3090, F 31, S 8, H V 54176, I/A 10(18.01.18).
07 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: VALLES SALES FRANCISCO;DOLZ PLA IGNACIO LUIS; CALVO ALONSO RAFAEL. Datosregistrales. T 5783, L 3090, F 31, S 8, H V 54176, I/A 9 (26.10.12).
17 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO ALONSO RAFAEL;DOLZ PLA IGNACIO LUIS;VALLES SALES FRANCISCO. Datosregistrales. T 5783, L 3090, F 30, S 8, H V 54176, I/A 8 ( 8.06.10).