Buscador CIF Logo

Actos BORME Ferrer Segarra Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ferrer Segarra Sociedad Anonima

Actos BORME Ferrer Segarra Sociedad Anonima - A46142477

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Ferrer Segarra Sociedad Anonima con CIF A46142477

馃敊 Perfil de Ferrer Segarra Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Ferrer Segarra Sociedad Anonima

06 de Marzo de 2023
Reelecciones. Consejero: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOSENRIQUE. Presidente: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL. Vicepresid.: FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT. Secretario:FERRER BURGOS ENRIQUE. Cons.Del.Sol: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOS MARIAMONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 149, S 8, H V 20000, I/A 38 (27.02.23).

03 de Agosto de 2021
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17.- ......"Retribuci贸n.- El cargo de administrador, en su condici贸n de tal es retribuido,consistiendo lo remuneraci贸n en una asignaci贸n fija dineraria, cuyo importe m谩ximo anual pura el conjunto de los administradores ser谩fijado por acuerdo de la junta general y permanecer谩 .........". Datos registrales. T 4171, L 1483, F 149, S 8, H V 20000, I/A 37(27.07.21).

07 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: DOLMAR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 149, S 8, H V 20000,I/A 36 (30.09.20).

25 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: DOLMAR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 149, S 8, H V 20000,I/A 35 (18.01.19).

21 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGOS FRANCES CONSUELO. Reelecciones. Consejero: FERRER BURGOS PASCUALMIGUEL;FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Presidente: FERRER BURGOS PASCUALMIGUEL. Vicepresid.: FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT. Secretario: FERRER BURGOS ENRIQUE. Cons.Del.Sol: FERRERBURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Datos registrales. T 4171,L 1483, F 147, S 8, H V 20000, I/A 33 (14.02.18).

19 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Auditor: MARTINEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 147, S 8, H V 20000, I/A 32 (12.11.14).

18 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGOS FRANCES CONSUELO;FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOSMARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Presidente: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL. Vicepresid.: FERRERBURGOS MARIA MONTSERRAT. Secretario: FERRER BURGOS ENRIQUE. Cons.Del.Sol: FERRER BURGOS PASCUALMIGUEL;FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: BURGOSFRANCES CONSUELO;FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT;FERRER BURGOSENRIQUE. Presidente: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL. Vicepresid.: FERRER BURGOS MARIA MONTSERRAT. Secretario:FERRER BURGOS ENRIQUE. Cons.Del.Sol: FERRER BURGOS PASCUAL MIGUEL;FERRER BURGOS MARIAMONTSERRAT;FERRER BURGOS ENRIQUE. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 98, S 8, H V 20000, I/A 31 (11.02.13).

29 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Aud.Supl.: MARTINEZ GARCIA MARIA JOSEP. Datos registrales. T4171, L 1483, F 98, S 8, H V 20000, I/A 30 (20.12.11).

11 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRER SEGARRA PASCUAL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 17.- Del Organo deAdministraci贸n. . Datos registrales. T 4171, L 1483, F 98, S 8, H V 20000, I/A 29 (30.12.10).

29 de Junio de 2009
Nombramientos. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Aud.Supl.: MARTINEZ GARCIA MARIA JOSEP. Datosregistrales. T 4171, L 1483, F 97, S 8, H V 20000, I/A 25 (18.06.09).

Nombramientos. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 97, S 8, H V 20000, I/A 26(18.06.09).

Nombramientos. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 4171, L 1483, F 97, S 8, H V 20000, I/A 27(18.06.09).

Nombramientos. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Aud.Supl.: MARTINEZ GARCIA MARIA JOSEP. Datosregistrales. T 4171, L 1483, F 97, S 8, H V 20000, I/A 28 (18.06.09).

16 de Junio de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.085,10 Euros. Resultante Suscrito: 212.092,90 Euros. Datos registrales. T 4171, L1483, F 97, S 8, H V 20000, I/A 24 ( 4.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n