Actos BORME de Ferroinox Sl
10 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: FERREIRO SEGADE VICTOR;FERNANDEZ PEREZ JAVIER. Datos registrales. T 521 , F 23, S 8, H LU9653, I/A 12 ( 3.09.20).
11 de Abril de 2019Reelecciones. Adm. Solid.: FERNANDEZ PEREZ JAVIER;SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Cambio de domicilio social. POLIG LACAMPI脩A S/N (LUGO). Datos registrales. T 329 , F 103, S 8, H LU 9653, I/A 11 ( 2.04.19).
27 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. C/ DOS CARROS 4.2.2 (LUGO). Datos registrales. T 329 , F 103, S 8, H LU 9653, I/A 10 (18.11.15).
05 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PEREZ JAVIER. Presidente: FERNANDEZ PEREZ JAVIER. Consejero: SIXTOGONZALEZ CHANTAL. Secretario: SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Consejero: GOMEZ VILAR ANGEL DOMINGO. Nombramientos.Adm. Solid.: FERNANDEZ PEREZ JAVIER;SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ TRANSPORTES-O CEAO177 (LUGO). Datos registrales. T 329 , F 103, S 8, H LU 9653, I/A 9 (26.05.14).
31 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ PEREZ JAVIER;SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Nombramientos. Consejero:FERNANDEZ PEREZ JAVIER. Presidente: FERNANDEZ PEREZ JAVIER. Consejero: SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Secretario:SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Consejero: GOMEZ VILAR ANGEL DOMINGO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.500,00 Euros.Resultante Suscrito: 53.900,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Consejo de administraci贸n.go de administrador.. Datos registrales. T 329 , F 101, S 8, H LU 9653, I/A 7 (16.12.09).
Nombramientos. Apoderado: SIXTO GONZALEZ CHANTAL. Datos registrales. T 329 , F 102, S 8, H LU 9653, I/A 8 (16.12.09).
04 de Diciembre de 2009Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL S/N (RABADE). Datos registrales. T 329 , F 101, S 8, H LU 9653, I/A 6(20.11.09).