Buscador CIF Logo

Actos BORME Ferrovial Internacional Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ferrovial Internacional Sl

Actos BORME Ferrovial Internacional Sl - B87124046

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ferrovial Internacional Sl con CIF B87124046

馃敊 Perfil de Ferrovial Internacional Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ferrovial Internacional Sl

29 de Marzo de 2019
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 34020 , F 77, S 8, H M 581266, I/A 30 (22.03.19).

25 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ECHANIZ URCELAY ALVARO;ECHANIZ URCELAY ALVARO. Apo.Sol.: SANCHEZ FERNANDEZALBERTO. Datos registrales. T 34020 , F 77, S 8, H M 581266, I/A 29 (18.02.19).

20 de Febrero de 2019
Fe de erratas: Se publico por error en la inscripci贸n 1M la publicaci贸n del poryecto de fusion, donde dice "aprobados por los Consejosde Administraci贸n de ambas entidades el 18 y 19 de diciembre de 2018" debe decir "aprobados por los Consejos de Administraci贸n deambas entidades el 18 y 20 de diciembre de 2018". Datos registrales. T 32294 , F 125, S 8, H M 581266, I/A 1M (11.02.19).

18 de Febrero de 2019
Otros conceptos: El 5 de febrero de 2019 ha quedado insertado en la p谩gina web corporativa de Ferrovial SA (www.ferrovial.com) elproyecto com煤n de fusi贸n de Ferrovial SA (Sociedad absorbente) y Ferrovial Internacional SL (Sociedad absorbida) aprobado por losConsejos de Administraci贸n de ambas entidades el 18 y 19 de diciembre de 2018, respectivamente.- Datos registrales. T 32294 , F125, S 8, H M 581266, I/A 1M (11.02.19).

19 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ-RATO REVUELTA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: GASTON NAJARRO JUANIGNACIO. Datos registrales. T 34020 , F 77, S 8, H M 581266, I/A 28 (12.12.18).

11 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;VERAMENDI B ALEJANDRO;PASCUAL OLIVA LUISALBERTO;LAFONT TORIO JUAN;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;MARTIN ROMERO MARIAELENA;CHOITHRAMANI BECERRA PABLO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;VERAMENDI B ALEJANDRO;PASCUAL OLIVA LUIS ALBERTO;LAFONTTORIO JUAN;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;SANCHEZ GUIJO FRANCISCO-JAVIER;TEJADA BIURRUNJORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA. Datos registrales. T 34020 , F 75, S 8, H M 581266, I/A 27 ( 3.12.18).

03 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVARES BLAZQUEZ SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ SORIA FIDEL. Datosregistrales. T 34020 , F 75, S 8, H M 581266, I/A 26 (25.06.18).

02 de Julio de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34020 , F 75, S 8, H M 581266, I/A 25 (25.06.18).

24 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: DE FELIPE Y FERNANDEZ LUIS IGNACIO;BERMEJO DIAZ GUSTAVO-ALBERTO;FLOREZ TELLACESAR;MALDONADO GARRIDO MARIA ANGELES;SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO;PASCUAL NU脩EZ CARLOSFRANCISCO;GUTIERREZ MORALEDA RAUL;TELLEZ REBOLLO JOSE LUIS;AVILA ROMERO JAVIER;MARTINEZ SANDEROSARIO;RODRIGUEZ ESTEBARANZ DANIEL. Nombramientos. Apo.Sol.: DE FELIPE FERNANDEZ LUIS IGNACIO;FLOREZTELLA CESAR;BERMEJO DIAZ GUSTAVO-ALBERTO;PASCUAL NU脩EZ CARLOS FRANCISCO;MALDONADO GARRIDO MARIAANGELES;SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO;GUTIERREZ MORALEDA RAUL;TELLEZ REBOLLO JOSE LUIS;AVILA ROMEROJAVIER;RODRIGUEZ ESTEBARANZ DANIEL;MARCOS ESPINOSA MARIA CARMEN. Datos registrales. T 34020 , F 73, S 8, H M581266, I/A 24 (13.10.17).

28 de Agosto de 2017
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: NORVAREM SA. Datos registrales. T 34020 , F 72, S 8, H M 581266, I/A 23(18.08.17).

18 de Mayo de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34020 , F 72, S 8, H M 581266, I/A 22 ( 8.05.17).

12 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: DE FELIPE Y FERNANDEZ LUIS IGNACIO;HERRANZ LUMBRERAS JESUS;LOSADA HERNANDEZPEDRO AGUSTIN. Datos registrales. T 34020 , F 67, S 8, H M 581266, I/A 20 (30.11.16).

22 de Agosto de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 61.627.075,00 Euros. Resultante Suscrito: 624.926.436,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 34020 , F 66, S 8, H M 581266, I/A 19 (11.08.16).

15 de Julio de 2016
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 22潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 34020 , F66, S 8, H M 581266, I/A 18 ( 7.07.16).

11 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO;LOPEZ MOZO ERNESTO;LOSADA HERNANDEZ PEDROAGUSTIN;PASCUAL OLIVA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 34020 , F 65, S 8, H M 581266, I/A 17 ( 3.03.16).

07 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME. Apo.Sol.: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME.Apoderado: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME. Apo.Manc.: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME. Datos registrales.T 32294 , F 154, S 8, H M 581266, I/A 16 (30.11.15).

22 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO. Nombramientos. SecreNoConsj: APILANEZ PEREZ DE ONRAITAEDUARDO. Datos registrales. T 32294 , F 154, S 8, H M 581266, I/A 14 (15.10.15).

21 de Octubre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FERROVIAL AGROMAN INTERNACIONAL SL. FERROVIAL SERVICIOSINTERNACIONAL SL. Datos registrales. T 32294 , F 152, S 8, H M 581266, I/A 13 ( 9.10.15).

20 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: APILANEZ PEREZ DE ONRAITA EDUARDO. Datos registrales. T 32294 , F 150, S 8, H M 581266, I/A12 ( 9.10.15).

10 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: CEREZO PAREDES CARLOS. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JUAN RAMON. Datosregistrales. T 32294 , F 149, S 8, H M 581266, I/A 11 (31.07.15).

25 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: HERRANZ LUMBRERAS JESUS. Datos registrales. T 32294 , F 147, S 8, H M 581266, I/A 9 (14.05.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: BONET GUTIERREZ CLAUDIO JOSE. Datos registrales. T 32294 , F 147, S 8, H M 581266, I/A 10(14.05.15).

09 de Enero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: RIDAURA CABALLERO ALICIA;CEREZO PAREDES CARLOS;AVELLO GARELLY GONZALO. Datosregistrales. T 32294 , F 143, S 8, H M 581266, I/A 7 (31.12.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME. Apo.Sol.: AGUIRRE DE CARCER Y MORENO JAIME.Datos registrales. T 32294 , F 145, S 8, H M 581266, I/A 8 (31.12.14).

04 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO. Datos registrales. T 32294 , F 135, S 8, H M 581266, I/A 5(26.11.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ MOZO ERNESTO. Datos registrales. T 32294 , F 139, S 8, H M 581266, I/A 6 (26.11.14).

28 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Presidente: MEIRAS AMUSCO I脩IGO. Secretario: ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO. Con.Delegado: MEIRASAMUSCO I脩IGO. Datos registrales. T 32294 , F 133, S 8, H M 581266, I/A 2 (21.11.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE FELIPE Y FERNANDEZ LUIS IGNACIO;BERMEJO DIAZ GUSTAVO-ALBERTO;FLOREZ TELLACESAR;MALDONADO GARRIDO MARIA ANGELES;SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO;PASCUAL NU脩EZ CARLOSFRANCISCO;GUTIERREZ MORALEDA RAUL;TELLEZ REBOLLO JOSE LUIS;AVILA ROMERO JAVIER;MARTINEZ SANDEROSARIO;RODRIGUEZ ESTEBARANZ DANIEL. Datos registrales. T 32294 , F 134, S 8, H M 581266, I/A 3 (21.11.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;VERAMENDI B ALEJANDRO;PASCUAL OLIVA LUISALBERTO;LAFONT TORIO JUAN;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;MARTIN ROMERO MARIAELENA;CHOITHRAMANI BECERRA PABLO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA. Datos registrales.T 32294 , F 135, S 8, H M 581266, I/A 4 (21.11.14).

12 de Noviembre de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.10.14. Objeto social: a) Dise帽o, construcci贸n, ejecuci贸n, explotaci贸n, gesti贸n,administarci贸n y conservaci贸n de infraestructuras y de obras p煤blicas y privadas, ya sea directamente o sea a trav茅s de la participaci贸nen sociedades, agrupaciones, consorcios o cualquiera otra an谩loga figura jur铆dica legalmente permitida en. Domicilio: C/ PRINCIPE DEVERGARA 135 (MADRID). Capital: 563.299.361,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FERROVIAL SA.Nombramientos. Consejero: MEIRAS AMUSCO I脩IGO;LOPEZ MOZO ERNESTO;ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO;DIAZ-RATOREVUELTA ENRIQUE;DE LA JOYA RUIZ DE VELASCO ALEJANDRO;OLIVARES BLAZQUEZ SANTIAGO;GIL VILLEN JORGE.Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32294 , F 125, S 8, H M 581266, I/A 1 ( 3.11.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n