Actos BORME de F&f Recmetal Sl
19 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP. Datos registrales. T 3610 , F 39, S 8, H A 130302, I/A 8(12.12.23).
26 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: MANYES MARQUINA ARISTIDES. Datos registrales. T 3610 , F 39, S 8, H A 130302, I/A 7(18.05.16).
25 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MANYES MARQUINA ARISTIDES;JOUHRI ZARZO MARIA LUISA;RODRIGUEZ BLANCO MARLENE.Datos registrales. T 3610 , F 39, S 8, H A 130302, I/A 6 (17.05.16).
22 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ COSIN FEDERICO. Datos registrales. T 3610 , F 38, S 8, H A 130302, I/A 5 (14.04.16).
21 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MANYES GIMENO HERMES. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ COSIN FERNANDO.Cambio de domicilio social. C/ ALISIOS 52 - POLIGONO INDUSTRIAL DE VALLONGA (ALICANTE). Datos registrales. T 3610 , F38, S 8, H A 130302, I/A 4 (13.04.16).
09 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: MANYES MARQUINA ARISTIDES. Nombramientos. Apo.Manc.: MANYES MARQUINAARISTIDES;JOUHRI ZARZO MARIA LUISA;RODRIGUEZ BLANCO MARLENE. Datos registrales. T 3610 , F 37, S 8, H A 130302,I/A 3 ( 1.08.13).
13 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: MANYES MARQUINA ARISTIDES. Datos registrales. T 3610 , F 37, S 8, H A 130302, I/A 2 ( 1.06.12).
12 de Junio de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 17.05.12. Objeto social: El comercio al por mayor de chatarra y otros residuos y desechosde hierro, acero, cobre, lat贸n, aluminio y otros metales, procedentes de m谩quinas, veh铆culos y otros materiales en desuso. Domicilio:AVDA MAISONNAVE 28 BIS 4 (ALICANTE). Capital: 3.100,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: MANYES GIMENO HERMES.Datos registrales. T 3610 , F 35, S 8, H A 130302, I/A 1 (31.05.12).