Actos BORME de Fhecor Ingenieros Consultores Sa
12 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CORRES PEIRETI HUGO. Vicepresid.: CORRES PEIRETI HUGO. Datos registrales. T 33405 , F177, S 8, H M 63935, I/A 55 ( 3.04.23).
18 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GALAN ALBERTO;BIANCHI MUNUERA DANIEL;LORENZO ROMERO JAVIER. Datosregistrales. T 33405 , F 177, S 8, H M 63935, I/A 54 (11.03.22).
09 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO;GOMEZ NAVARRO MIGUEL.Datos registrales. T 33405 , F 177, S 8, H M 63935, I/A 53 ( 2.03.22).
03 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: VERAE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33405 , F 176, S 8, H M 63935, I/A 52 (27.01.22).
16 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: CORRES PEIRETTI HUGO EDUARDO. Datos registrales. T 33405 , F 176, S 8, H M 63935, I/A 50 (9.06.20).
Revocaciones. Apoderado: CORRES PEIRETTI GUILLERMO. Datos registrales. T 33405 , F 176, S 8, H M 63935, I/A 51 (9.06.20).
09 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ POZUELO JAVIER;GARCIA JIMENEZ HECTOR. Datos registrales. T 33405 , F 175, S8, H M 63935, I/A 49 ( 2.03.20).
24 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: SANZ MANZANEDO CRISTINA. Datos registrales. T 33405 , F 174, S 8, H M 63935, I/A 46(17.01.20).
Nombramientos. Apoderado: ANDUEZA OLMEDO JAVIER. Datos registrales. T 33405 , F 174, S 8, H M 63935, I/A 47 (17.01.20).
Nombramientos. Apoderado: BRAVO NOTARIO FERNANDO. Datos registrales. T 33405 , F 175, S 8, H M 63935, I/A 48(17.01.20).
03 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: GOMEZ NAVARRO MIGUEL. Datos registrales. T 33405 , F 173, S 8, H M 63935, I/A 45 (26.09.19).
24 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: ROMO MARTIN JOSE. Secretario: PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO. Cons.Del.Sol: ROMOMARTIN JOSE. Nombramientos. Consejero: TORRICO LIZ JAVIER. Con.Delegado: ROMO MARTIN JOSE. Presidente: PEREZCALDENTEY ALEJANDRO. Vicepresid.: CORRES PEIRETI HUGO. Secretario: TORRICO LIZ JAVIER. Reelecciones. Consejero:CORRES PEIRETI HUGO;ROMO MARTIN JOSE;LEON GONZALEZ JAVIER;PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO. Vicesecret.: LEONGONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 33405 , F 173, S 8, H M 63935, I/A 44 (17.06.19).
04 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: RIVERO GARCIA LINO. Datos registrales. T 33405 , F 172, S 8, H M 63935, I/A 43 (29.05.19).
17 de Diciembre de 2018Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 11潞 de los estatutos sociales. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de lap谩gina web corporativa: www.fhecor.es. Datos registrales. T 33405 , F 172, S 8, H M 63935, I/A 42 (10.12.18).
28 de Agosto de 2018Nombramientos. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33405 , F 171, S 8, H M 63935, I/A 41 (21.08.18).
11 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RIVERO GARCIA LINO. Datos registrales. T 33405 , F 171, S 8, H M 63935, I/A 40 ( 4.05.18).
04 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33405 , F 171, S 8, H M 63935, I/A 39 (28.01.16).
26 de Junio de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 48.160,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:431.840,00 Euros. Desembolsado: 431.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 480.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 480.000,00Euros. Datos registrales. T 16982 , F 100, S 8, H M 63935, I/A 38 (19.06.15).
14 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: LEON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;TORRICO LIZ JAVIER;ROMERO REY EDUARDO DE LOSSANTOS;PRIETO AGUILERA FRANCISCO;RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO. Otros conceptos: Ratificar todos los actos de lasescrituras otorgadas por el Notario autorizante, el 14 de Marzo de 2007, con el n潞 988, que causo la ins 24 y la de 14 de Octubre de2010, con el n潞 3424, que causo la ins.31. Datos registrales. T 16982 , F 99, S 8, H M 63935, I/A 37 ( 6.04.15).
31 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CORRES PEIRETI HUGO. Cons.Del.Sol: CORRES PEIRETI HUGO. Revocaciones. Apoderado:CORRES PEIRETTI HUGO EDUARDO. Datos registrales. T 16982 , F 99, S 8, H M 63935, I/A 36 (23.07.14).
16 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO. Datos registrales. T 16982 , F 98, S 8, H M 63935, I/A 35 (8.05.14).
22 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROMO MARTIN JOSE. Nombramientos. Consejero: CORRES PEIRETI HUGO;ROMO MARTINJOSE;LEON GONZALEZ JAVIER;PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO. Vicepresid.: CORRES PEIRETI HUGO. Presidente: ROMOMARTIN JOSE. Secretario: PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO. Vicesecret.: LEON GONZALEZ JAVIER. Cons.Del.Sol: ROMOMARTIN JOSE;CORRES PEIRETI HUGO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nicoa Consejo de administraci贸n.SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 16982 , F 96, S 8, H M 63935, I/A34 (14.10.13).
22 de Enero de 2013Nombramientos. Auditor: ADHOC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16982 , F 96, S 8, H M 63935, I/A 33 (10.01.13).
07 de Abril de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.757,64 Euros. Resultante Suscrito: 40.442,36 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:19.757,64 Euros. Desembolsado: 19.757,64 Euros. Resultante Suscrito: 60.200,00 Euros. Resultante Desembolsado: 60.200,00 Euros.Datos registrales. T 16982 , F 96, S 8, H M 63935, I/A 32 (28.03.11).
26 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO;PEREZ CALDENTEY ALEJANDRO RAFAEL. Datos registrales.T 16982 , F 94, S 8, H M 63935, I/A 31 (16.11.10).
13 de Julio de 2010Ampliacion del objeto social. LA ELABORACION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS INFORMATICOS, ASI COMO LAASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO SOBRE LOS MISMOS, ETC. Datos registrales. T 16982 , F 93, S 8, H M 63935, I/A 29( 2.07.10).
Nombramientos. Apoderado: LEON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;TORRICO LIZ JAVIER;ROMERO REY EDUARDO DE LOSSANTOS;PRIETO AGUILERA FRANCISCO. Datos registrales. T 16982 , F 93, S 8, H M 63935, I/A 30 ( 2.07.10).
01 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: ADHOC AUDITORES SL. Datos registrales. T 16982 , F 93, S 8, H M 63935, I/A 28 (20.01.10).