Buscador CIF Logo

Actos BORME Fidelity Information Services -iberia- Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fidelity Information Services -iberia- Sl

Actos BORME Fidelity Information Services -iberia- Sl - B79531562

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fidelity Information Services -iberia- Sl con CIF B79531562

🔙 Perfil de Fidelity Information Services -iberia- Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fidelity Information Services -iberia- Sl

25 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: DAUGHTREY VIRGINIA ANNE. Apoderado: WARREN THOMAS KENNETH;MOLLINEDO MONTERO DEESPINOSA JOSE. Nombramientos. Apoderado: ISLA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 34113 , F 220,S 8, H M 11981, I/A 59 (18.09.23).

17 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: GILES LINDA CHRISTINE. Apoderado: BOYD MARTIN ROBERT;BALDWIN ANGELA. Nombramientos.Apo.Manc.: LANG LORI LYNNE;SHUYAMA ANDRES KEN;ALLEY ALEXANDER;BATEMAN ANDREW;RIVETT MICHELLE. Datosregistrales. T 34113 , F 219, S 8, H M 11981, I/A 57 (10.03.23).

10 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: WALLIS HOWARD. Consejero: MAYO MARC M. Presidente: MAYO MARC M. Revocaciones.Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;PEREZ-HERNANDEZ DURAN MARIA;MORENES HOYOS PATRICIO;SANCHEZCALERO BARCO SOFIA CANDIDA. Apoderado: MAYO MARC M. Nombramientos. SecreNoConsj: KIMBER KERIN. Consejero:

28 de Febrero de 2020
Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 132 9ª (MADRID). Datos registrales. T 34113 , F 216, S 8, H M 11981,I/A 55 (21.02.20).

08 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALVES MONTEIRO ANA FILIPA. Apoderado: LOADER GRAHAM PHILIP. Nombramientos.Apoderado: BALDWIN ANGELA. Datos registrales. T 34113 , F 216, S 8, H M 11981, I/A 54 ( 1.08.19).

21 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: BROWN JOY E;MCHUGH JOSEPH F;GUITART CARRERO MOIRA. Apo.Man.Soli: WARD PAULETTE.Apoderado: MULLANE KAREN M;SUNGARD SYSTEMS LTD;BDO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL. Apo.Sol.:FRANCO PIÑEIRO ALVARO. Apoderado: CLARKSON STUART. Nombramientos. Apoderado: LOADER GRAHAM PHILIP. Datosregistrales. T 34113 , F 215, S 8, H M 11981, I/A 53 (13.09.18).

16 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: OATES MICHAEL PETER. Presidente: OATES MICHAEL PETER. Revocaciones. Apoderado:OATES MICHAEL PETER. Nombramientos. Consejero: MAYO MARC M. Presidente: MAYO MARC M. Apoderado: MAYO MARC M.Datos registrales. T 34113 , F 213, S 8, H M 11981, I/A 52 ( 6.04.18).

26 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: HALLGREN KHADIJA OUJOUD. Datos registrales. T 34113 , F 213, S 8, H M 11981, I/A 51(18.01.18).

30 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL PINO AGUILERA ALVARO. Revocaciones. Apo.Manc.: DEL PINO AGUILERA ALVARO.Nombramientos. Apoderado: BOYD MARTIN ROBERT;CLARKSON STUART. Modificaciones estatutarias. Modificación delartículo 32 de los Estatutos sociales . Datos registrales. T 34113 , F 212, S 8, H M 11981, I/A 49 (22.08.17).

18 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ ESCRIBANO SILVIA. Datos registrales. T 34113 , F 211, S 8, H M 11981, I/A 48(10.01.17).

03 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: APPADU VANESSA AMRITHA;COUTURIER JASON LYDELL. Presidente: COUTURIER JASONLYDELL. Revocaciones. Apoderado: APPADU VANESSA AMRITHA;APPADU VANESSA AMRITHA. Apo.Manc.: SHEEHAN MARKEDWARD. Apoderado: COUTURIER JASON LYDELL. Apo.Manc.: COUTURIER JASON LYDELL. Nombramientos. Presidente:

13 de Diciembre de 2016
Declaración de unipersonalidad. Socio único: FIS SYSTEMS INTERNATIONAL LLC. Datos registrales. T 34113 , F 208, S 8, HM 11981, I/A 46 ( 1.12.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información