Buscador CIF Logo

Actos BORME Fidere Screen Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fidere Screen Sl

Actos BORME Fidere Screen Sl - B88003306

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fidere Screen Sl con CIF B88003306

🔙 Perfil de Fidere Screen Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fidere Screen Sl

14 de Agosto de 2023
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social . Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO DECOMPOSTELA 94 3ª (MADRID). Datos registrales. T 37014 , F 199, S 8, H M 661312, I/A 21 ( 7.08.23).

20 de Julio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ OROZCO ELENA. Datos registrales. T 37014 , F 199, S 8, H M 661312, I/A 19 (13.07.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MANCEBO CAMPOS MAITE. Datos registrales. T 37014 , F 199, S 8, H M 661312, I/A 20(13.07.23).

19 de Julio de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ GARCIA LAURA. VsecrNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF. Nombramientos.SecreNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF. Datos registrales. T 37014 , F 198, S 8, H M 661312, I/A 18 (12.07.23).

22 de Mayo de 2023
Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 6 y 7 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 37014 , F 197, S 8, HM 661312, I/A 17 (12.05.23).

27 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;FIDERE RESIDENCIAL SL;BERRAL ZURITA ANDRES;MURCIARABADAN PABLO;MELLA LOPEZ VICTOR;ARRIBAS SAIZ PATRICIA;MILIAN DUEÑAS LAURA;KOSTADINOV VASILEVPANAYOT;DEY SHOMIT;MEDIANE ANISSA;LEFEBVRE PIERRE YVES;VERA MARTIN JUAN PABLO;TRIGOS ROMEROANTONIO;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;IZQUIERDO SEBASTIAN OLIVIA;MARTINEZ GARCIA PIEDAD;GARCIA SANCHEZJUAN-MANUEL;LUENGO REGALADO SANTOS MANUEL;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN. Nombramientos.Apoderado: MARQUEZ BLANCO MANUEL;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADE MARTIN. Datos registrales. T 37014 , F197, S 8, H M 661312, I/A 16 (20.02.23).

09 de Junio de 2022
Otros conceptos: Subsanación de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, doña Maria del Rosario de Miguel Rosesel 12 de febrero de 2021, número 410 de su protocolo, que causó la inscripción 10ª de la Hoja social. Datos registrales. T 37014 , F196, S 8, H M 661312, I/A 15 ( 2.06.22).

07 de Junio de 2022
Otros conceptos: Subsanación de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, doña Maria del Rosario de Miguel Rosesel 18 de mayo de 2020, número 1289 de su protocolo, que causó la inscripción 8ª de la Hoja social. Datos registrales. T 37014 , F196, S 8, H M 661312, I/A 14 (31.05.22).

18 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: VERA MARTIN JUAN PABLO;ROSON GOMEZ NOELIA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;IZQUIERDOSEBASTIAN OLIVIA;FERNANDEZ NAVARRO CARLOS;CAVA MARTINEZ MARIO;LUENGO REGALADO SANTOSMANUEL;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN. Datos registrales. T 37014 , F 194, S 8, H M 661312, I/A 13 (11.03.22).

23 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOFFMANN SOLVEIG DIANA. Nombramientos. Consejero: CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL. Datos registrales. T 37014 , F 194, S 8, H M 661312, I/A 12 (16.08.21).

13 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOSSY JEAN FRANCOIS;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Presidente: BOSSY JEAN FRANCOIS.Vicepresid.: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Nombramientos. Presidente: VERA MARTIN JUAN PABLO. Consejero: BAUTISTABLAZQUEZ FERNANDO;ROCH DOROTA MARTA;VERA MARTIN JUAN PABLO. Datos registrales. T 37014 , F 193, S 8, H M661312, I/A 11 ( 6.05.21).

15 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: CABEZAS DIAZ DANIEL;ABAD VERA RAUL;GARCIA-FERRIOL VAZQUEZ MARIA AUXILIADORA.Datos registrales. T 37014 , F 193, S 8, H M 661312, I/A 10 ( 8.03.21).

21 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: NEIRA BUSTAMANTE SELINA. Nombramientos. VsecrNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF.Datos registrales. T 37014 , F 192, S 8, H M 661312, I/A 9 (14.12.20).

01 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BERRAL ZURITA ANDRES. Nombramientos. Vicepresid.: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO.VsecrNoConsj: NEIRA BUSTAMANTE SELINA. Datos registrales. T 37014 , F 192, S 8, H M 661312, I/A 7 (25.05.20).

Nombramientos. Apoderado: ABAD VERA RAUL;GARCIA-FERRIOL VAZQUEZ MARIA AUXILIADORA. Datos registrales. T 37014, F 192, S 8, H M 661312, I/A 8 (25.05.20).

24 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: TESTA HOME SL;VERA MARTIN JUAN PABLO;TRIGOS ROMERO ANTONIO;SAN JOSE DESANTIAGO DIEGO;IZQUIERDO SEBASTIAN OLIVIA;MARTINEZ GARCIA PIEDAD;GARCIA SANCHEZ JUAN-MANUEL;LUENGOREGALADO SANTOS MANUEL;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN. Datos registrales. T 37014 , F 130, S 8, H M 661312,I/A 6 (17.02.20).

28 de Junio de 2019
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 257 (MADRID). Datos registrales. T 37014 , F 130, S 8, H M 661312,I/A 5 (21.06.19).

18 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;DEY SHOMIT;BOSSY JEANFRANCOIS;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;VERA MARTIN JUAN PABLO;CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL;LEFEBVRE PIERRE YVES;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA. Datos registrales. T 37014 , F 129, S 8,H M 661312, I/A 4 ( 9.10.18).

21 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;NOVOA BERREDODANIEL;BOSSY JEAN FRANCOIS;HOFFMAN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;VERA MARTIN JUAN PABLO;CABALLEROMARTINEZ JOSE GABRIEL;LEFEBVRE PIERRE YVES;HALFORD KATRINA;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA.Datos registrales. T 37014 , F 128, S 8, H M 661312, I/A 3 (14.03.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información