Buscador CIF Logo

Actos BORME Fidere Vivienda 3 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fidere Vivienda 3 Sl

Actos BORME Fidere Vivienda 3 Sl - B86988508

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fidere Vivienda 3 Sl con CIF B86988508

馃敊 Perfil de Fidere Vivienda 3 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fidere Vivienda 3 Sl

25 de Agosto de 2023
Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA 94 3潞 (MADRID). Datos registrales. T 35258 , F 91, S 8, H M579390, I/A 31 (18.08.23).

20 de Julio de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ GARCIA LAURA. VsecrNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF. Nombramientos.SecreNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF. Datos registrales. T 35258 , F 90, S 8, H M 579390, I/A 28 (13.07.23).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ OROZCO ELENA. Datos registrales. T 35258 , F 91, S 8, H M 579390, I/A 29 (13.07.23).

Nombramientos. Apoderado: MANCEBO CAMPOS MAITE. Datos registrales. T 35258 , F 91, S 8, H M 579390, I/A 30 (13.07.23).

29 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: RODRIGO GARCIA GUILLERMO;BERRAL ZURITA ANDRES;BENAVIDES GRASESALFONSO;GUILLEN BASTANTE JUAN IGNACIO;TIRADO ANULA ANDRES GUILLERMO;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;DESANTIAGO TORRENTE OSCAR;BERDULLAS POMARES JUAN JOSE;RODRIGUEZ SANCHEZ SUSANA;BUISAN LACHEN BELENMARIA;GONZALEZ PILA DANIEL;ALVAREZ UCAR ALEJANDRA;ROMERO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 35258 , F

27 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: FIDERE RESIDENCIAL SL. Apo.Sol.: TIRADO ANULA ANDRES GUILLERMO;BERRAL ZURITAANDRES;GUILLEN BASTANTE JUAN IGNACIOApoderado: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;ROSAS RAMOSSAMUEL;FERNANDEZ GARCIA LAURA;MELLA LOPEZ VICTOR;SANCHEZ-MINGUET VAZQUEZ ESPERANZA;ARRIBAS SAIZPATRICIA;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;MEDIANE ANISSA;LEFEBVRE PIERRE YVES;LUENGO REGALADO SANTOSMANUEL;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN;MARTINEZ GARCIA PIEDAD;TRIGOS ROMERO ANTONIO;VERA MARTINJUAN PABLO;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;IZQUIERDO SEBASTIAN OLIVIA;GARCIA SANCHEZ JUAN-MANUEL.Nombramientos. Apoderado: MARQUEZ BLANCO MANUEL;SANCHEZ-PAMPLONA SANCHEZ-RAMADE MARTIN. Datosregistrales. T 35258 , F 89, S 8, H M 579390, I/A 26 (20.02.23).

14 de Septiembre de 2022
Otros conceptos: Subsanaci贸n de la escritura de poder otorgada en Madrid, el 12 de febrero de 2021, ante la notario de Madrid,Mar铆a del Rosario de Miguel Roses, n煤mero 412 de protocolo, que caus贸 la inscripci贸n 20陋 de la hoja social. Datos registrales. T35258 , F 89, S 8, H M 579390, I/A 25 ( 7.09.22).

13 de Septiembre de 2022
Otros conceptos: Subsanaci贸n de la escritura de poder otorgada en Madrid, el 18 de mayo de 2020, ante la notario de Madrid, do帽aMar铆a de Rosario de Miguel Roses, n煤mero 1316 de protocolo, que caus贸 la inscripci贸n 18陋 de la hoja social. Datos registrales. T35258 , F 89, S 8, H M 579390, I/A 24 ( 6.09.22).

23 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: VERA MARTIN JUAN PABLO;ROSON GOMEZ NOELIA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;IZQUIERDOSEBASTIAN OLIVIA;FERNANDEZ NAVARRO CARLOS;CAVA MARTINEZ MARIO;LUENGO REGALADO SANTOS

23 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOFFMAN SOLVEIG DIANA. Nombramientos. Consejero: CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL. Datos registrales. T 35258 , F 86, S 8, H M 579390, I/A 22 (16.08.21).

13 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOSSY JEAN FRANCOIS;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Presidente: BOSSY JEAN FRANCOIS.Vicepresid.: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Nombramientos. Presidente: VERA MARTIN JUAN PABLO. Consejero: BAUTISTABLAZQUEZ FERNANDO;ROCH DOROTA MARTA;VERA MARTIN JUAN PABLO. Datos registrales. T 35258 , F 86, S 8, H M579390, I/A 21 ( 6.05.21).

24 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABEZAS DIAZ DANIEL. Datos registrales. T 35258 , F 86, S 8, H M 579390, I/A 20 (17.02.21).

21 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: NEIRA BUSTAMANTE SELINA. Nombramientos. VsecrNoConsj: LOBELOS SAN JOSE ENIF.Datos registrales. T 35258 , F 85, S 8, H M 579390, I/A 19 (14.12.20).

02 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BERRAL ZURITA ANDRES. Nombramientos. Vicepresid.: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO.Vicesecret.: NEIRA BUSTAMANTE SELINA. Datos registrales. T 35258 , F 84, S 8, H M 579390, I/A 17 (26.05.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABAD VERA RAUL;GARCIA-FERRIOL VAZQUEZ MARIA AUXILIADORA. Datos registrales. T35258 , F 85, S 8, H M 579390, I/A 18 (26.05.20).

26 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: LUENGO REGALADO SANTOS MANUEL;GARCIA DEL CASTILLO DE LAMA CARMEN;TESTAHOME SL;MARTINEZ GARCIA PIEDAD;TRIGOS ROMERO ANTONIO;VERA MARTIN JUAN PABLO;SAN JOSE DE SANTIAGODIEGO;IZQUIERDO SEBASTIAN OLIVIA;GARCIA SANCHEZ JUAN-MANUEL. Datos registrales. T 35258 , F 82, S 8, H M 579390,I/A 16 (19.02.20).

01 de Julio de 2019
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 257 (MADRID). Datos registrales. T 35258 , F 82, S 8, H M 579390, I/A15 (24.06.19).

04 de Junio de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 8 y 10 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 35258 , F 81, S 8,H M 579390, I/A 14 (24.05.18).

18 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;NOVOA BERREDODANIEL;BOSSY JEAN FRANCOIS;HOFFMAN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;VERA MARTIN JUAN PABLO;CABALLEROMARTINEZ JOSE GABRIEL;LEFEBVRE PIERRE YVES;HALFORD KATRINA;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA.Datos registrales. T 35258 , F 78, S 8, H M 579390, I/A 13 (29.11.17).

11 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LAVISIER INVESTMENTS SL. Representan: SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;BOSSY JEAN FRANCOIS;O脩ATE RINOMIGUEL;RIVAS GONZALEZ FRANCISCO;OLLERO BARRERA MIGUEL;LAZARO GOMEZ LUIS;DE PABLO REPES XABIERMARIANO;CABALLERO JOSE. Nombramientos. Consejero: HOFFMAN SOLVEIG DIANA;BOSSY JEAN FRANCOIS;SAN JOSE DESANTIAGO DIEGO. Presidente: BOSSY JEAN FRANCOIS. SecreNoConsj: FERNANDEZ GARCIA LAURA. VsecrNoConsj: BERRALZURITA ANDRES. Apoderado: BOSSY JEAN FRANCOIS;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO;HOFFMAN SOLVEIG DIANA;ROSASRAMOS SAMUEL;FERNANDEZ GARCIA LAURA;MELLA LOPEZ VICTOR;SANCHEZ-MINGUET VAZQUEZ ESPERANZA;ARRIBASSAIZ PATRICIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 35258 , F 78, S 8, H M 579390, I/A 12 (29.11.17).

16 de Diciembre de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 46 - OFICINA 1-D (MADRID). Datos registrales. T 35258 , F 78, S 8, H M579390, I/A 11 ( 7.12.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n