Actos BORME de Fillmore Corporate Sl
19 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MA脩EZ BELLOT FRANCISCO;MA脩EZ BELLOT JOSE MARIA. Nombramientos. Liquidador:MA脩EZ BELLOT FRANCISCO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 16(12.11.21).
23 de Febrero de 2021Revocaciones. Auditor: AUDITORES EXTERNOS SLP. Datos registrales. T 27606 , F 29, S 8, H M 434082, I/A 15 (16.02.21).
17 de Febrero de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 608.034,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.766,00 Euros. Datos registrales. T 27606 , F29, S 8, H M 434082, I/A 14 (10.02.21).
30 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: AUDITORES EXTERNOS SLP. Datos registrales. T 27606 , F 28, S 8, H M 434082, I/A 13 (22.12.20).
30 de Noviembre de 2017Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 20 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 27606 , F 28, S 8, H M434082, I/A 12 (23.11.17).
06 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ QUILES JUAN MANUEL. Datos registrales. T 27606 , F 27, S 8, H M 434082, I/A 11(28.03.17).
03 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA ASENSI JAVIER. Datos registrales. T 27606 , F 27, S 8, H M 434082, I/A 10 (24.02.16).
23 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 27606 , F 26, S 8, H M 434082, I/A 9(13.03.12).
20 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PERNICHIMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 27606 , F 25, S 8, H M 434082, I/A 8 (10.01.11).
19 de Octubre de 2010Ampliacion del objeto social. LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON PRACTICA DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS VINCULADASAL MUNDO DEL MOTOR. EN RELACION CON LO ANTERIOR, ES ASIMISMO OBJETO DELA SOCIEDAD EL DISE脩O,CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y GESTION DE PARQUES DE OCIO EN TODAS LAS VARIANTES CONTEMPLADAS POR LALEGISLACION. Datos registrales. T 27606 , F 24, S 8, H M 434082, I/A 7 ( 7.10.10).
08 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 27606 , F 23, S 8, H M 434082, I/A 6(24.03.10).
06 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 90 (MADRID). Datos registrales. T 24154 , F 76, S 8, H M 434082, I/A 4 (23.03.10).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Solid.: MA脩EZ BELLOTFRANCISCO;MA脩EZ BELLOT JOSE MARIA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 650.790,00 Euros. Resultante Suscrito: 653.800,00Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Otrosconceptos: MODIFICADO EL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALESY RENUMERACION DE LASMISMASREFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Ampliacion del objeto social. CUALQUIER ACTIVIDADRELACIONADA CON LA PRACTICA DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS VINCULADAS AL MUNDO DEL MOTOR. Datos registrales.T 24154 , F 78, S 8, H M 434082, I/A 5 (23.03.10).
29 de Diciembre de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 2679 , F 31, S 8, H MU 71792, I/A 3 (17.12.09).
07 de Mayo de 2009Cambio de domicilio social. PRAJE DE LA RAJA S/N (JUMILLA). Datos registrales. T 2679 , F 31, S 8, H MU 71792, I/A 2(27.04.09).
18 de Marzo de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Ceses/Dimisiones.Adm. Unico: TORA CASTELLANOS RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ PERNICHI MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 3303 , F 24, S 8, H A 113035, I/A 3 ( 3.03.09).