Buscador CIF Logo

Actos BORME Fincas De Boadilla Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fincas De Boadilla Sociedad Anonima

Actos BORME Fincas De Boadilla Sociedad Anonima - A28120004

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fincas De Boadilla Sociedad Anonima con CIF A28120004

馃敊 Perfil de Fincas De Boadilla Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fincas De Boadilla Sociedad Anonima

15 de Abril de 2021
Nombramientos. Auditor: ASESORES GENERALES SLP. Datos registrales. T 39315 , F 171, S 8, H M 118081, I/A 40 ( 8.04.21).

29 de Enero de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16, 20, 26, 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICIONDE LOS ARTICULOS 4 BIS), 16 BIS) Y 20 BIS) DE DICHOS ESTATUTOS.. Datos registrales. T 39315 , F 168, S 8, H M 118081, I/A39 (22.01.21).

24 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA. Presidente: SUAREZ ARNAL MANUEL.Secretario: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Vicesecret.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: SUAREZ ARNALMANUEL;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;MARTINEZ GALA MANUEL. Nombramientos.Consejero: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Presidente: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Consejero: DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JAVIER. Vicepresid.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: MARTINEZ GALA MANUEL.Secretario: MARTINEZ GALA MANUEL. Consejero: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA;CEBRIANHERNANDEZ ALVARO CARLOS. Datos registrales. T 39315 , F 167, S 8, H M 118081, I/A 38 (17.11.20).

06 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;MARTINEZGALA MANUEL. Datos registrales. T 7287 , F 195, S 8, H M 118081, I/A 37 (30.08.19).

28 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: SUAREZ ARNAL MANUEL;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTINEDUARDO;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Apo.Sol.: CEBRIAN AGUSTINEDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Apoderado: MARTINEZ GALA MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.:CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;MARTINEZ GALA MANUEL. Datos registrales.T 7287 , F 193, S 8, H M 118081, I/A 36 (19.12.18).

21 de Mayo de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 272,19 Euros. Resultante Suscrito: 161.378,40 Euros. Otros conceptos: Renumeracion

22 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: ASESORES GENERALES SLP. Datos registrales. T 7287 , F 186, S 8, H M 118081, I/A 34 (12.01.18).

11 de Enero de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 22.908,17 Euros. Resultante Suscrito: 161.650,59 Euros. Datos registrales. T 7287 , F184, S 8, H M 118081, I/A 33 (29.12.17).

11 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GALA MANUEL. Datos registrales. T 7287 , F 184, S 8, H M 118081, I/A 32 (30.11.17).

24 de Agosto de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 50.485,02 Euros. Resultante Suscrito: 201.940,06 Euros. Datos registrales. T 7287 , F182, S 8, H M 118081, I/A 30 (16.08.17).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 17.381,30 Euros. Resultante Suscrito: 184.558,76 Euros. Datos registrales. T 7287 , F183, S 8, H M 118081, I/A 31 (16.08.17).

28 de Marzo de 2017
Nombramientos. Consejero: MARTINEZ GALA MANUEL. Datos registrales. T 7287 , F 182, S 8, H M 118081, I/A 29 (17.03.17).

17 de Agosto de 2016
Modificaciones estatutarias. 16. Funcionamiento Junta General.-. Datos registrales. T 7287 , F 181, S 8, H M 118081, I/A 28 (2.08.16).

06 de Octubre de 2015
Reelecciones. Consejero: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA. Presidente: SUAREZ ARNAL MANUEL.Secretario: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Vicesecret.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: SUAREZ ARNALMANUEL;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Datos registrales. T 7287 , F 181, S 8, H M118081, I/A 27 (25.09.15).

24 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CEBRIAN HERNANDO EDUARDO. Nombramientos. Consejero: DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA. Reelecciones. Presidente: SUAREZ ARNAL MANUEL. Secretario: CEBRIAN AGUSTINEDUARDO. Vicesecret.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: SUAREZ ARNAL MANUEL;DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Datos registrales. T 7287 , F 181, S 8, H M 118081, I/A 26 (15.07.13).

27 de Enero de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Datos registrales. T 7287 ,F 180, S 8, H M 118081, I/A 25 (17.01.11).

16 de Febrero de 2009
Reelecciones. Consejero: CEBRIAN HERNANDO EDUARDO. Presidente: SUAREZ ARNAL MANUEL. Secretario: CEBRIANAGUSTIN EDUARDO. Vicesecret.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: SUAREZ ARNAL MANUEL;DE LAHERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Datos registrales. T 7287 , F 180, S 8, H M 118081, I/A 24 (5.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n