Actos BORME de First Wave Services Sl
25 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RODRIGUEZ AGUIRRE CRISTOBAL SABINO. Datos registrales. T 36161 , F 39, S 8, H M396995, I/A 14 (18.11.22).
29 de Agosto de 2022Nombramientos. Adm. Solid.: ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 12º Y 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de domicilio social. C/ RIBERA DEL LOIRA 28 (MADRID).Datos registrales. T 36161 , F 35, S 8, H M 396995, I/A 12 (22.08.22).
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO;FERNANDEZ ALONSO DANIEL;PEREZ HERNANDEZ JOSERAMON;HERVAS ZURITA MONTSERRAT;DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO;SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL;BASCONES PEREZFRAGERO MIGUEL;BADILLO SERRANO ANTONIO;VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE;GONZALEZ PILAR MARIA PAZ;MUÑOZREDONDO VANESA. Datos registrales. T 36161 , F 36, S 8, H M 396995, I/A 13 (22.08.22).
25 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: RENOVABLES ATLASOL SA. Datos registrales. T 36161 , F 35, S8, H M 396995, I/A 11 (18.10.21).
03 de Marzo de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SOLARES DE ATLASCO SL. Modificaciones estatutarias.Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales.. Datos registrales. T 36161 , F 34, S 8, H M 396995, I/A 10 (24.02.21).
05 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE LA ENSENADA 14 (MADRID). Datos registrales. T 36161 , F 34, S 8, H M 396995,I/A 9 (27.02.20).
24 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: LYBAERT ALEXANDRA SILVIA;MINJAW PAUL FRANCIS M;VILLANUEVA VILLA JAVIER. Datosregistrales. T 36161 , F 34, S 8, H M 396995, I/A 8 (16.08.18).
14 de Julio de 2017Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE LA ENSENADA 14 - 1ª PLANTA, OFICINA (MADRID). Datos registrales. T 36161 ,F 34, S 8, H M 396995, I/A 7 ( 6.07.17).
26 de Mayo de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: MARTIN GRUSCHKA. APODERAD.SOL: CASANOVA SANCHEZ MICKAEL. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: RODRIGUEZ AGUIRRE CRISTOBAL SABINO;MATESANZ POSTIGO FERMIN. Otros conceptos: CAMBIO DESOCIO UNICO, PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO "EOLIA GREGAL DE INVERSIONES, SA". Datos registrales. T 45401, F 122, S 8, H B 366905, I/A 24 (15.05.17).
18 de Octubre de 2016Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 30/06/2016. Fusión porabsorción. Sociedades absorbidas: PS ARVASOLAR TRACKED 1 SL. PS ARVASOLAR TRACKED 2 SL. PS ARVASOLARTRACKED 3 SL. PS ARVASOLAR TRACKED 4 SL. PS ARVASOLAR FIXED 5 SL. PS ARVASOLAR FIXED 6 SL. PS ARVASOLARFIXED 7 SL. PS ARVASOLAR FIXED 8 SL. PS ARVASOLAR FIXED 9 SL. PS ARVASOLAR FIXED 10 SL. PS ARVASOLAR FIXED11 SL. PS ARVASOLAR FIXED 12 SL. PS 1 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 2 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS3 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 4 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 5 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL.PS 6 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 7 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 8 EL ROBLEDO PROYECTO SOLARSL. PS 9 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 10 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. PS 11 EL ROBLEDO PROYECTOSOLAR SL. PS 12 EL ROBLEDO PROYECTO SOLAR SL. Datos registrales. T 42561 , F 199, S 8, H B 366905, I/A 23 ( 6.10.16).
26 de Octubre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: CASANOVA SANCHEZ MICKAEL. Datos registrales. T 42561 , F 198, S 8, H B 366905, I/A 22(16.10.15).
21 de Julio de 2015Revocaciones. ADM.CONJUNTO: SECO BARRAGAN ALEJANDRO;MARTIN GRUSCHKA. Nombramientos. ADM.UNICO:MARTIN GRUSCHKA. Datos registrales. T 42561 , F 197, S 8, H B 366905, I/A 20 (14.07.15).
Revocaciones. APODERAD.SOL: SECO BARRAGAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 42561 , F 198, S 8, H B 366905, I/A 21(14.07.15).
14 de Octubre de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: PARODI CONCHES MARTIN. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: SECO BARRAGANALEJANDRO;MARTIN GRUSCHKA. Datos registrales. T 42561 , F 194, S 8, H B 366905, I/A 18 ( 7.10.14).
Revocaciones. APODERADO: ALEXANDRA SILVIA LYBAERT;PARODI CONCHES MARTIN. Nombramientos. APODERAD.SOL:SECO BARRAGAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 42561 , F 194, S 8, H B 366905, I/A 19 ( 7.10.14).
18 de Diciembre de 2013Revocaciones. APODERADO: PAUL FRANCIS M MINJAW. ADM.UNICO: RIK NORBERT RENE MISSAULT. Nombramientos.ADM.UNICO: PARODI CONCHES MARTIN. Datos registrales. T 42561 , F 194, S 8, H B 366905, I/A 17 (11.12.13).
23 de Agosto de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: STEVEN DE TOLLENAERE. Nombramientos. ADM.UNICO: RIK NORBERT RENE MISSAULT.Datos registrales. T 42561 , F 192, S 8, H B 366905, I/A 15 (10.08.12).
Nombramientos. APODERADO: PARODI CONCHES MARTIN. Datos registrales. T 42561 , F 192, S 8, H B 366905, I/A 16(10.08.12).
29 de Junio de 2012Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GINO HECTOR MARIA VAN NEER;PATRICK DE CUYPER. Nombramientos. ADM.UNICO:STEVEN DE TOLLENAERE. Datos registrales. T 42561 , F 191, S 8, H B 366905, I/A 14 (18.06.12).
22 de Agosto de 2011Revocaciones. APODERADO: GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL. Datos registrales. T 42561 , F 191, S 8, H B 366905,I/A 12 ( 9.08.11).
Revocaciones. APODERADO: LARS PETER. Datos registrales. T 42561 , F 191, S 8, H B 366905, I/A 13 ( 9.08.11).
09 de Mayo de 2011Nombramientos. APODERADO: LARS PETER. Datos registrales. T 40546 , F 205, S 8, H B 366905, I/A 11 (27.04.11).
08 de Marzo de 2010Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GOTICA LINK SL. BRIDGE BOREAL SL. Datos registrales. T 40546 , F 201, S 8, HB 366905, I/A 10 (23.02.10).
26 de Agosto de 2009Nombramientos. APODERADO: GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL. Datos registrales. T 40546 , F 200, S 8, H B 366905,I/A 9 (14.08.09).
08 de Julio de 2009Revocaciones. APODERADO: VILLENUEVA VILLA JAVIER. Datos registrales. T 40546 , F 200, S 8, H B 366905, I/A 8 (26.06.09).