Buscador CIF Logo

Actos BORME Fomento De Inversiones Las Marias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fomento De Inversiones Las Marias Sl

Actos BORME Fomento De Inversiones Las Marias Sl - B83531814

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fomento De Inversiones Las Marias Sl con CIF B83531814

馃敊 Perfil de Fomento De Inversiones Las Marias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fomento De Inversiones Las Marias Sl

27 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: TUREGANO RUIZ INES;MONTEIRO DE MENESES FERREIRA RUI JORGESANGREMAN;MARTINEZ-NORIEGA CAMPUZANO ANGEL. Datos registrales. T 41121 , F 32, S 8, H M 320626, I/A 29 (19.12.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: HOLGADO HERRERO MANUEL;HERRAEZ SANCHEZ OSCAR;MOLINA CUBILLO BELEN. Datosregistrales. T 41121 , F 34, S 8, H M 320626, I/A 30 (19.12.22).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RENAU JORGE;VICARIO DEL POZO SANTIAGO;TUREGANO RUIZ INES;DE MIGUELBALSA CRISTINA;MONTEIRO DE MENESES FERREIRA RUI JORGE SANGREMAN;MARTINEZ-NORIEGA CAMPUZANO ANGEL.Datos registrales. T 41121 , F 37, S 8, H M 320626, I/A 31 (19.12.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RENAU JORGE;VICARIO DEL POZO SANTIAGO;BLASCO BLANCO JAVIER;MUNGUIRAFERNANDEZ ROSA;PORTILLO RUIZ FRANCISCO JOSE;MONTEIRO DE MENESES FERREIRA RUI JORGE SANGREMAN. Datosregistrales. T 41121 , F 38, S 8, H M 320626, I/A 32 (19.12.22).

11 de Octubre de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 676/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 16/09/2022. Auto de conclusi贸n delconcurso. Pago a los acreedores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID. Juez: MANUEL RUIZDE LARA. Datos registrales. T 41121 , F 32, S 8, H M 320626, I/A 28 ( 4.10.22).

25 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: HOLGADO HERRERO MANUEL;HERRAEZ SANCHEZ OSCAR. Datos registrales. T 41121 , F 30, S8, H M 320626, I/A 27 (18.02.21).

10 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: LABIEB MAJDA;RUIZ PORTILLO FRANCISCO JOSE;BLASCO BLANCO JAVIER;MUNGUIRAFERNANDEZ ROSA;MARTINEZ-NORIEGA CAMPUZANO ANGEL. Datos registrales. T 18465 , F 18, S 8, H M 320626, I/A 26 (3.02.21).

29 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO;FRAILE LAMEYER FEDERICO;MEDINA HERNANDO VICTOR.SecreNoConsj: RUIZ GARAMENDI MARTA. Presidente: MEDINA HERNANDO VICTOR. Nombramientos. Adm. Unico: LASMARIAS DEVELOPMENTS SL. Representan: OCEJO CALVO IGNACIO MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 18465 , F 18, S 8, H M 320626, I/A 25(21.12.20).

03 de Julio de 2020
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 676/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/06/2020. Resoluciones acordando laintervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID. Juez: DON MANUEL RUIZ DE LARA. Resoluciones: ACUERDO DE MODIFICACION DELREGIMEN DE FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE LA CONCURSADA, DE FORMA QUE SERAN EJERCIDASPOR LA CONCURSADA EN REGIMEN DE INTERVENCION, DEJANDOSE DE APLICAR EL INCREMENTO DEL 50% DELOSARANCELES ADOPTADO EN EL AUTO DE FIJACION DE HONORARIOS. Datos registrales. T 18465 , F 18, S 8, H M 320626, I/AC (26.06.20).

26 de Julio de 2018
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 676/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 5/06/2018. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DO脩A CARMEN GONZALEZ SUAREZ.Resoluciones: APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO, CONVOCANDOSE JUNTA DE ACREEDORES PARA EL DIA 27 DESEPTIEMBRE DE 2018. Datos registrales. T 18465 , F 17, S 8, H M 320626, I/A B (19.07.18).

29 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BECERRIL MORA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: SCHULLER MORENO AMADOR;BUENO CA脩ETEFRANCISCO;TOBIAS RODRIGUEZ CARLOS. Apo.Sol.: RUIZ GARAMENDI MARTA. Apoderado: RUIZ GARAMENDI MARTA.Apo.Manc.: RUIZ GARAMENDI MARTA;RODRIGUEZ OLIVIER. Nombramientos. Apoderado: REPULLO SANCHEZ ALBERTO.Datos registrales. T 18465 , F 17, S 8, H M 320626, I/A 24 (18.08.16).

11 de Julio de 2016
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 676/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/06/2016. Auto de declaraci贸n deconcurso. Necesario. Juzgado: num. 11 JUZGADO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DO脩A CARMEN GONZALEZ SUAREZ.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 676/2014. Fecha de resoluci贸n 17/06/2016. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 11 JUZGADO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DO脩A CARMEN GONZALEZ SUAREZ. Administrador Concursal.Fecha 17/06/2016, NIF/CIF 05679383Q. SERRANO SANCHEZ MANUELA. Datos registrales. T 18465 , F 17, S 8, H M 320626, I/A A( 4.07.16).

11 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: FRAILE LAMEYER FEDERICO. Nombramientos. Presidente: MEDINA HERNANDO VICTOR.Datos registrales. T 18465 , F 16, S 8, H M 320626, I/A 23 ( 1.04.16).

21 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO. Nombramientos. Presidente: FRAILE LAMEYER FEDERICO.Datos registrales. T 18465 , F 16, S 8, H M 320626, I/A 22 (13.04.15).

25 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: MEDINA HERNANDO VICTOR. Nombramientos. Presidente: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO.Datos registrales. T 18465 , F 16, S 8, H M 320626, I/A 21 (17.03.14).

12 de Junio de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ GARAMENDI MARTA;RODRIGUEZ OLIVIER. Datos registrales. T 18465 , F 16, S 8, H M320626, I/A 20 ( 4.06.13).

04 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: FRAILE LAMEYER FEDERICO. Nombramientos. Presidente: MEDINA HERNANDO VICTOR.Datos registrales. T 18465 , F 15, S 8, H M 320626, I/A 19 (27.05.13).

17 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO. Nombramientos. Presidente: FRAILE LAMEYER FEDERICO.Datos registrales. T 18465 , F 15, S 8, H M 320626, I/A 18 ( 6.08.12).

23 de Noviembre de 2011
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 18465 , F 15, S 8, H M 320626, I/A 17(14.11.11).

11 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: MEDINA HERNANDO VICTOR. Nombramientos. Presidente: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO.Datos registrales. T 18465 , F 14, S 8, H M 320626, I/A 16 (31.03.11).

03 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: URETA SAORIN ELOY ANTONIO;URETA SAORIN MARTA MARIA;URETA SAORIN MARIA ROCIO.Cons.Del.Man: URETA SAORIN MARIA ROCIO;URETA SAORIN MARTA MARIA;URETA SAORIN ELOY. Consejero: MEDINAHERNANDO VICTOR. Cons.Del.Man: MEDINA HERNANDO VICTOR. Presidente: URETA SAORIN MARIA ROCIO. Secretario: RUIZGARAMENDI MARTA. Nombramientos. Consejero: PEREZ-DURIAS RUBIO GERARDO;FRAILE LAMEYER FEDERICO;MEDINAHERNANDO VICTOR. Datos registrales. T 18465 , F 13, S 8, H M 320626, I/A 14 (21.02.11).

Nombramientos. SecreNoConsj: RUIZ GARAMENDI MARTA. Apoderado: RUIZ GARAMENDI MARTA. Presidente: MEDINAHERNANDO VICTOR. Datos registrales. T 18465 , F 14, S 8, H M 320626, I/A 15 (21.02.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n