Buscador CIF Logo

Actos BORME Fomento De San Sebastian Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fomento De San Sebastian Sa

Actos BORME Fomento De San Sebastian Sa - A20001681

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Fomento De San Sebastian Sa con CIF A20001681

馃敊 Perfil de Fomento De San Sebastian Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Fomento De San Sebastian Sa

21 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOIA LASO ENEKO;MENDARTE AZKUE MIREN NEKANE;HERVAS SAEZ DE ARREGUI MIRENJAIONE;ORMAZABAL GAZTA脩AGA JON MARKEL;DUARTE LOPEZ OLAIA;LAGE MANICH CRISTINA;GARMENDIA BELOQUIMARIA-SOLEDAD;COROMINAS FISAS BORJA;SACRISTAN ESTEBAN BIXENTE MIRENA. Presidente: GOIA LASO ENEKO.Vicepresid.: GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD. Nombramientos. Consejero: GOIA LASO ENEKO;ITURRI ARRAZOLAITZIAR;VITORIA ROMA JABIER;MENDARTE AZCUE MIREN NEKANE;ORBEGOZO URIBE KERMAN;GARMENDIA BELOQUIMARIA-SOLEDAD;LAGE MANICH CRISTINA;COROMINAS FISAS BORJA;LASA BRIZ VICTOR JOSE. Presidente: GOIA LASOENEKO. Vicepresid.: GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD. Datos registrales. T 2528 , F 165, S 8, H SS 4857, I/A 87(14.09.23).

17 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SESE SARASTI EUGENIO-MARIA. Fe de erratas: No se revoc贸 el poder conferido a D. Euken SeseSarasti, por no figurar inscrito, cuando este constaba en la inscripci贸n 52陋.- Datos registrales. T 2528 , F 165, S 8, H SS 4857, I/A 85 (9.06.22).

03 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA JAIME. Nombramientos. Consejero: HERVAS SAEZ DEARREGUI MIREN JAIONE. Datos registrales. T 2528 , F 164, S 8, H SS 4857, I/A 83 (26.05.22).

Nombramientos. Apoderado: OLAIZOLA ARCAUTE I脩IGO. Datos registrales. T 2528 , F 164, S 8, H SS 4857, I/A 84 (26.05.22).

02 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Vicepresid.: GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD. Datos registrales. T 2528 , F 163, S 8, H SS 4857, I/A 80(23.08.21).

Revocaciones. Apoderado: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE. Nombramientos. Apoderado: GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD. Datos registrales. T 2528 , F 163, S 8, H SS 4857, I/A 81 (23.08.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Nombramientos. Consejero: LAGE MANICH CRISTINA. Datosregistrales. T 2528 , F 164, S 8, H SS 4857, I/A 82 (23.08.21).

03 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: BETEAN AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2528 , F 163, S 8, H SS 4857, I/A 79 (27.01.21).

29 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE. Vicepresid.: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE.Nombramientos. Consejero: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Datos registrales. T 2528 , F 162, S 8, H SS 4857, I/A 78 (19.10.20).

15 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: OYARBIDE OCHOA ANE;GURPEGUI RUIZ ALFONSO;VILES MITXELENA JUAN RAMON;GOIALASO ENEKO;DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA JAIME;GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE;RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA;MARTIN GARIN AMAIA;ALBISTUR GARMENDIA MIREN. Presidente: GOIA LASO ENEKO. Vicepresid.: GASCO GONZALOERNESTO-JOSE. Nombramientos. Consejero: GOIA LASO ENEKO;MENDARTE AZKUE MIREN NEKANE;DOMINGUEZ-MACAYALAURNAGA JAIME;ORMAZABAL GAZTA脩AGA JON MARKEL;DUARTE LOPEZ OLAIA;GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD;GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE;COROMINAS FISAS BORJA;GARAY GALLASTEGUI HAIZEA. Presidente: GOIALASO ENEKO. Vicepresid.: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE. Datos registrales. T 2528 , F 162, S 8, H SS 4857, I/A 77(30.09.20).

13 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: PALOS BARBERO MARIA BEGO脩A. Nombramientos. Consejero: OYARBIDE OCHOA ANE.Datos registrales. T 2528 , F 162, S 8, H SS 4857, I/A 76 ( 1.03.18).

17 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: BETEAN AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2528 , F 162, S 8, H SS 4857, I/A 75 ( 9.01.18).

06 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Nombramientos. Consejero: GURPEGUI RUIZ ALFONSO.Datos registrales. T 2528 , F 161, S 8, H SS 4857, I/A 74 (30.03.16).

29 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: IZAGUIRRE HORTELANO JUAN CARLOS;RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA;ERASO ITURRIOTZMARIA LURDES;GARCIA CHUECA SUSANA;RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE;GOMEZ UGALDE RAMON;ARRUE PINTO JOSELUIS;GURRUTXAGA ARMENDARIZ I脩AKI;SAN ROMAN ABETE AITZIBER. Presidente: IZAGUIRRE HORTELANO JUAN CARLOS.Vicepresid.: RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA. Nombramientos. Consejero: GOIA LASO ENEKO;VILES MITXELENA JUANRAMON;DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA JAIME;GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE;RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE;PALOSBARBERO MARIA BEGO脩A;RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA;ALBISTUR GARMENDIA MIREN;MARTIN GARIN AMAIA. Presidente:GOIA LASO ENEKO. Vicepresid.: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE. Datos registrales. T 2528 , F 161, S 8, H SS 4857, I/A 71(19.01.16).

Revocaciones. Apoderado: RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA. Datos registrales. T 2528 , F 161, S 8, H SS 4857, I/A 72 (19.01.16).

Nombramientos. Apoderado: GASCO GONZALO ERNESTO-JOSE. Datos registrales. T 2528 , F 161, S 8, H SS 4857, I/A 73(19.01.16).

24 de Junio de 2015
Ampliacion del objeto social. Art铆culo 2.- Objeto social y funciones. l.- La Sociedad, que carece de 谩nimo de lucro, tendr谩 por objetola promoci贸n, desarrollo y potenciaci贸n de las actividades econ贸micas y sociales que contribuyan, directa e indirectamente a impulsarel desarrollo del sistema productivo y del empleo del 谩mbito. Datos registrales. T 2528 , F 160, S 8, H SS 4857, I/A 70 (17.06.15).

20 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: CONSULTORES Y AUDITORES ALTER 1990 SLP. Datos registrales. T 2528 , F 160, S 8, H SS 4857, I/A69 ( 5.01.15).

04 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBISTUR GARMENDIA MIREN;VICENTE MOROCHO MARIA ESTHER. Nombramientos.Consejero: GOMEZ UGALDE RAMON;ARRUE PINTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2528 , F 160, S 8, H SS 4857, I/A 68(22.02.13).

19 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ UGALDE RAMON;ARRUE PINTO JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: ALBISTURGARMENDIA MIREN;VICENTE MOROCHO MARIA ESTHER. Datos registrales. T 2528 , F 160, S 8, H SS 4857, I/A 67 (11.12.12).

20 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA. Datos registrales. T 2528 , F 159, S 8, H SS 4857, I/A 66 (11.04.12).

26 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Datos registrales. T 2528 , F 159, S 8, H SS 4857, I/A 65 (14.03.12).

02 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: CONSULTORES Y AUDITORES ALTER 1990 SLP. Datos registrales. T 2528 , F 159, S 8, H SS 4857, I/A64 (24.01.12).

15 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ELORZA GONZALEZ ODON. Presidente: ELORZA GONZALEZ ODON. Consejero: RAMOS VISPOENRIQUE-JOSE. Vicepresid.: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Consejero: GARMENDIA BELOQUI MARIA-SOLEDAD;GARCIACHUECA SUSANA;ARRUE PINTO JOSE LUIS;SAN ROMAN ABETE AITZIBER;ALBIZU AGIRREZABALAGA JON;IRAZABALBEITIAFERNANDEZ I脩AKI;MARTIN EGURZA MIGUEL-MARIA. Nombramientos. Consejero: RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA;IZAGIRREHORTELANO JUAN-CARLOS;ERASO ITURRIOTZ MARIA LURDES;GARCIA CHUECA SUSANA;RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE;GOMEZ UGALDE RAMON;ARRUE PINTO JOSE LUIS;GURRUTXAGA ARMENDARIZ I脩AKI;SAN ROMAN ABETE AITZIBER.Presidente: IZAGIRRE HORTELANO JUAN-CARLOS. Vicepresid.: RUIZ MARTIN JOSU-MIRENA. Datos registrales. T 2528 , F 159,S 8, H SS 4857, I/A 63 ( 3.11.11).

07 de Diciembre de 2010
Otros conceptos: Nueva redacci贸n de Estatutos Sociales para que estos tenganun texto unitario. Datos registrales. T 2204 , F 212,S 8, H SS 4857, I/A 62 (25.11.10).

03 de Diciembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 908.549,96 Euros. Desembolsado: 908.549,96 Euros. Resultante Suscrito: 9.604.699,06 Euros.Resultante Desembolsado: 9.604.699,06 Euros. Otros conceptos: Modificaci贸n de los ARTICULOS 7潞 y 8潞 de los Estatutos Socialesrelativos al Capital social y acciones. Datos registrales. T 2204 , F 211, S 8, H SS 4857, I/A 60 (24.11.10).

Cambio de objeto social. Gesti贸n y explotaci贸n de negocios hoteleros,la cultura, el ocio, aparcamientoLa sociedad tiene condici贸n demedio propio y servicio t茅cnico de la Administraci贸n P煤blica.No podr谩 participar en licitaciones p煤blicas convocadaspor laAdministraci贸n que ostenta en ella la condici贸n de accionista 煤nico. Datos registrales. T 2204 , F 211, S 8, H SS 4857, I/A 61(24.11.10).

14 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ITXASO GONZALEZ DENIS. Nombramientos. Consejero: GARCIA CHUECA SUSANA. Datosregistrales. T 2204 , F 210, S 8, H SS 4857, I/A 59 ( 6.05.10).

02 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRATIBEL ARRONDO JAIONE;URANGA MUELAS JON. Nombramientos. Consejero: MARTINEGURZA MIGUEL-MARIA;ALBIZU AGIRREZABALAGA JON. Datos registrales. T 2204 , F 210, S 8, H SS 4857, I/A 58 (22.01.10).

08 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: RAMOS VISPO ENRIQUE-JOSE. Datos registrales. T 2204 , F 210, S 8, H SS 4857, I/A 57(28.08.09).

06 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBIZU AGIRREZABALAGA JON;SANCHO COSCOLLUELA CARLOS. Nombramientos.Consejero: IRAZABALBEITIA FERNANDEZ I脩AKI;ARRUE PINTO JOSE LUIS. Datos registrales. T 2204 , F 210, S 8, H SS 4857, I/A56 (26.06.09).

19 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORCUERA LEUNDA SUSANA;IRAZABALBEITIA FERNANDEZ I脩AKI;ARRUE PINTO JOSE LUIS.Nombramientos. Consejero: ITXASO GONZALEZ DENIS;ALBIZU AGIRREZABALAGA JON;SANCHO COSCOLLUELA CARLOS.Datos registrales. T 2204 , F 209, S 8, H SS 4857, I/A 55 ( 9.06.09).

01 de Abril de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.484.004,00 Euros. Desembolsado: 1.484.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.696.149,10 Euros.Resultante Desembolsado: 8.696.149,10 Euros. Datos registrales. T 2204 , F 208, S 8, H SS 4857, I/A 54 (23.03.09).

27 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: SESE SARASTI EUGENIO-MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SESE SARASTI EUGENIO-MARIA. Datos registrales. T 2204 , F 207, S 8, H SS 4857, I/A 52 (17.03.09).

Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 14潞, 17潞 Y 20潞 DE LOS ESTATUTOS, EN CUANTO A FACULTADES DELCONSEJO, DEL PRESIDENTE Y DELGERENTE. Datos registrales. T 2204 , F 208, S 8, H SS 4857, I/A 53 (17.03.09).

04 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: USANDIZAGA RODRIGUEZ MARIA-JOSE. Nombramientos. Consejero: ARRUE PINTO JOSELUIS. Datos registrales. T 2204 , F 207, S 8, H SS 4857, I/A 51 (23.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n