Buscador CIF Logo

Actos BORME Fomento Inmobiliario Levantino Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fomento Inmobiliario Levantino Sl

Actos BORME Fomento Inmobiliario Levantino Sl - B96821731

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fomento Inmobiliario Levantino Sl con CIF B96821731

馃敊 Perfil de Fomento Inmobiliario Levantino Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fomento Inmobiliario Levantino Sl

27 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: REALIA BUSINESS SA;REALIA PATRIMONIO SL;ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIOSL;TRINIDAD 6 SL. Presidente: ESTUDIOS DE INVESTIGACION SERVICIO SL. Consejero: VALAISE SL. Secretario: RICHI ALBERTIJOSE MARIA. Representan: FRANCO DIEZ JUAN-ANTONIO;LLADRO ROIG JUAN VICENTE;LLADRO ROIG JUANVICENTE;HERNANDEZ GOMEZ ANA;RODRIGUEZ ARELLANO FRANCISCO. Nombramientos. LiquiSoli: LLADRO ROIG JUANVICENTE;HERNANDEZ GOMEZ ANA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 25695 , F 210, S 8, H M 463138, I/A18 (17.11.15).

27 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: FIGUEROA NAVARRO ANGEL. Datos registrales. T 25695 , F 210, S 8, H M 463138, I/A 17 (19.05.14).

28 de Febrero de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 307.988,00 Euros. Resultante Suscrito: 699.216,00 Euros. Datos registrales. T 25695 , F113, S 8, H M 463138, I/A 16 (21.02.13).

20 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: PINILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ARELLANOFRANCISCO. Datos registrales. T 25695 , F 113, S 8, H M 463138, I/A 15 (10.07.12).

21 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: PINILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: RODRIGUEZARELLANO FRANCISCO. Datos registrales. T 25695 , F 113, S 8, H M 463138, I/A 14 ( 7.03.12).

23 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apoderado: MARIN ZARZA TOMAS. Datos registrales. T 25695 , F 113, S 8, H M 463138, I/A 13 (10.08.11).

04 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: MARIN ZARZA TOMAS. Nombramientos. Representan: HERNANDEZ GOMEZ ANA. Datosregistrales. T 25695 , F 113, S 8, H M 463138, I/A 12 (21.01.11).

15 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: BROTONS TORRES VICENTE. Consejero: PORTFOLIO DE GRANDES AREAS COMERCIALESSA. Nombramientos. Representan: PINILLA GARCIA JAVIER. Consejero: VALAISE SL. Datos registrales. T 25695 , F 112, S 8, HM 463138, I/A 11 ( 4.10.10).

29 de Junio de 2010
Revocaciones. Apoderado: BROTONS TORRES VICENTE ESTEBAN. Datos registrales. T 25695 , F 112, S 8, H M 463138, I/A 10(17.06.10).

27 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: LLADRO ROIG DAVID. Nombramientos. Representan: LLADRO ROIG JUAN VICENTE. Datosregistrales. T 25695 , F 112, S 8, H M 463138, I/A 9 (16.04.10).

21 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: LLADRO ROIG INMACULADA. Nombramientos. Representan: LLADRO ROIG JUAN VICENTE.Datos registrales. T 25695 , F 112, S 8, H M 463138, I/A 8 (12.04.10).

29 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Representan: BROTONS TORRES VICENTE. Nombramientos. Representan: PINILLA GARCIA FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 25695 , F 111, S 8, H M 463138, I/A 7 (16.12.09).

06 de Julio de 2009
Revocaciones. Apoderado: CALDUCH FALCO ANA EVA;LLADRO ROIG INMACULADA. Nombramientos. Apoderado: LLADROROIG JUAN VICENTE. Datos registrales. T 25695 , F 111, S 8, H M 463138, I/A 6 (23.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n