Buscador CIF Logo

Actos BORME Fonderia Especial Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fonderia Especial Sa

Actos BORME Fonderia Especial Sa - A08917387

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Fonderia Especial Sa con CIF A08917387

馃敊 Perfil de Fonderia Especial Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Fonderia Especial Sa

09 de Marzo de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.620.106,25 Euros. Desembolsado: 2.620.106,25 Euros. Resultante Suscrito: 4.784.102,25 Euros.Resultante Desembolsado: 4.784.102,25 Euros. Datos registrales. T 41922 , F 140, S 8, H B 93135, I/A 41 ( 3.03.23).

07 de Marzo de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: GUBERT CERT ROGER. Datos registrales. T 41922 , F 137, S 8, H B 93135, I/A 39 (28.02.23).

Nombramientos. APODERAD.SOL: RIUMBAU CALAF JOSE MARIA. Datos registrales. T 41922 , F 137, S 8, H B 93135, I/A 40(28.02.23).

06 de Marzo de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INOX TEGA 080 S.L. Datos registrales. T 41992 , F 135, S 8, H B 93135, I/A 38(24.02.23).

20 de Enero de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: TANKER GRUP 10 SL. REPR.143 RRM: RIUMBAU CALAF JOSE MARIA. PRESIDENTE: TANKERGRUP 10 SL. OBSER.CON.AD: MASSAGUER AGULLO MIQUEL. CONSEJERO: TERRA EXPORT SL. SECRETARIO: TERRAEXPORT SL. REPR.143 RRM: PRIETO ROMERO ENRIC. CONSEJERO: GUTIERREZ XIVILLE MARIO;PLANAS SAUTER JORDI.CONS.DEL.SOL: PLANAS SAUTER JORDI. Nombramientos. ADM.UNICO: PLANAS SAUTER JORDI. Datos registrales. T 41922

22 de Diciembre de 2022
Revocaciones. ADM.UNICO: NAMAX PARTNERS SL. REPR.143 RRM: GUBERT CERT ROGER. Nombramientos. CONSEJERO:TANKER GRUP 10 SL. REPR.143 RRM: RIUMBAU CALAF JOSE MARIA. PRESIDENTE: TANKER GRUP 10 SL. OBSER.CON.AD:MASSAGUER AGULLO MIQUEL. CONSEJERO: TERRA EXPORT SL. SECRETARIO: TERRA EXPORT SL. REPR.143 RRM:PRIETO ROMERO ENRIC. CONSEJERO: GUTIERREZ XIVILLE MARIO;PLANAS SAUTER JORDI. CONS.DEL.SOL: PLANASSAUTER JORDI. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 23 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 40916 , F 119, S 8, H B 93135, I/A 33 (14.12.22).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 903.853,04 Euros. Desembolsado: 903.853,04 Euros. Resultante Suscrito: 2.063.995,34 Euros.Resultante Desembolsado: 2.063.995,34 Euros. Datos registrales. T 41922 , F 134, S 8, H B 93135, I/A 34 (14.12.22).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 100.000,66 Euros. Desembolsado: 100.000,66 Euros. Resultante Suscrito: 2.163.996,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.163.996,00 Euros. Datos registrales. T 41922 , F 134, S 8, H B 93135, I/A 35 (14.12.22).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SLP. Datos registrales. T 41922 , F 134, S 8, H B93135, I/A 36 (14.12.22).

19 de Agosto de 2020
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SLP. Datos registrales. T 40916 , F 119, S 8, H B93135, I/A 32 (11.08.20).

18 de Diciembre de 2019
Revocaciones. ADM.UNICO: RIUMBAU CALAF JOSE MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: NAMAX PARTNERS DOINGBUSINESS SL. REPR.143 RRM: GUBERT CERT ROGER. Datos registrales. T 40916 , F 119, S 8, H B 93135, I/A 31 (10.12.19).

02 de Abril de 2019
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: FRANMELIC ASSESSORS SL. REPR.143 RRM: MANZANARES MIRAS MARCOS ANTONIO.ADM.SOLIDAR.: RIMBI SL. REPR.143 RRM: RIUMBAU CALAF JUAN. Nombramientos. ADM.UNICO: RIUMBAU CALAF JOSEMARIA. Datos registrales. T 40916 , F 118, S 8, H B 93135, I/A 30 (26.03.19).

30 de Enero de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: GUBERT CERT ROGER. Datos registrales. T 40916 , F 117, S 8, H B 93135, I/A 29(22.01.19).

02 de Diciembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 117, S 8, H B93135, I/A 28 (25.11.16).

20 de Septiembre de 2016
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: FRANMELIC ASSESSORS SL. REPR.143 RRM: MANZANARES MIRAS MARCOS ANTONIO.ADM.SOLIDAR.: RIMBI SL. REPR.143 RRM: RIUMBAU CALAF JUAN. Datos registrales. T 40916 , F 116, S 8, H B 93135, I/A 27(12.09.16).

23 de Agosto de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 116, S 8, H B93135, I/A 26 (16.08.16).

03 de Noviembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 116, S 8, H B93135, I/A 25 (27.10.14).

25 de Noviembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 116, S 8, H B93135, I/A 24 (15.11.13).

19 de Agosto de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 116, S 8, H B93135, I/A 23 ( 9.08.13).

05 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 40916 , F113, S 8, H B 93135, I/A 22 (22.02.13).

19 de Octubre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 113, S 8, H B93135, I/A 21 ( 7.10.11).

22 de Septiembre de 2011
Revocaciones. ADM.UNICO: FRANMELIC ASSESSORS SL. REPR.143 RRM: MANZANARES MIRAS MARCOS ANTONIO.Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: FRANMELIC ASSESSORS SL. REPR.143 RRM: MANZANARES MIRAS MARCOS ANTONIO.ADM.SOLIDAR.: RIMBI SL. REPR.143 RRM: RIUMBAU CALAF JUAN. Modificaciones estatutarias. ART.14:MODIFICACION ENLA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 40916 , F 112, S 8, H B 93135, I/A 20(12.09.11).

28 de Abril de 2009
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: VERIFICACIONS FINANCERES I COMPTABLES AUDITORS ASS. Nombramientos.AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 40916 , F 112, S 8, H B 93135, I/A 19(15.04.09).

02 de Abril de 2009
Revocaciones. ADM.UNICO: RIVAS LOPEZ JUAN. Nombramientos. ADM.UNICO: FRANMELIC ASSESSORS SL. REPR.143RRM: MANZANARES MIRAS MARCOS ANTONIO. Datos registrales. T 40916 , F 111, S 8, H B 93135, I/A 18 (19.03.09).

13 de Enero de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 60.111,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.160.142,30 Euros. Datos registrales. T 25694 , F29, S 8, H B 93135, I/A 17 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n