Buscador CIF Logo

Actos BORME Food Delivery Brands Group Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Food Delivery Brands Group Sa

Actos BORME Food Delivery Brands Group Sa - A84342229

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Food Delivery Brands Group Sa con CIF A84342229

馃敊 Perfil de Food Delivery Brands Group Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Food Delivery Brands Group Sa

04 de Diciembre de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 44719 , F 206, S 8, H M 381118, I/A 124 (27.11.23).

20 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLER CELESTINO JACOBO. Presidente: CALLER CELESTINO JACOBO. Con.Delegado:CALLER CELESTINO JACOBO. Nombramientos. Presidente: CLARKE JASON RICHARD LEE. Datos registrales. T 44719 , F205, S 8, H M 381118, I/A 123 (13.11.23).

07 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: CALLER CELESTINO JACOBO;CALLER CELESTINO JACOBO;CALLER CELESTINOJACOBO;CALLER CELESTINO JACOBO. Nombramientos. Apoderado: RENEDO JIMENEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T44719 , F 202, S 8, H M 381118, I/A 122 (30.10.23).

19 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTIN GARCIA IGNACIO;MARTIN GARCIA IGNACIO. Datos registrales. T 44719 , F 202, S 8, H M381118, I/A 121 (11.10.23).

11 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: BARRIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 44719 , F 202, S 8, H M 381118, I/A 120 (4.08.23).

31 de Julio de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 73.898,50 Euros. Resultante Suscrito: 25.106.271,25 Euros. Datos registrales. T 44719 ,F 201, S 8, H M 381118, I/A 119 (24.07.23).

26 de Julio de 2023
Otros conceptos: Modificado, en cuanto a error material, el proyecto de fusi贸n de fecha 27 de junio de 2023, entre "FOODDELIVERY BRANDS SAU" como sociedad absorbente, y "FOOD DELIVERY BRANDS GROUP SA", "FOODCO BONDCO SA" y"MIXOR SA" como sociedades absorbidas. Datos registrales. T 21430 , F 4, S 8, H M 381118, I/A 3-M (19.07.23).

15 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: CALLER CELESTINO JACOBO. Consejero: TASTY BIDCO SL. Con.Delegado: TASTY BIDCO SL.Presidente: TASTY BIDCO SL. Nombramientos. Consejero: CALLER CELESTINO JACOBO;CLARKE JASON RICHARD LEE.Datos registrales. T 40626 , F 222, S 8, H M 381118, I/A 114 ( 8.06.23).

Modificaciones estatutarias. Nueva redacci贸n del art铆culo 6 de los estatutos.. Datos registrales. T 40626 , F 223, S 8, H M 381118,I/A 115 ( 8.06.23).

Nombramientos. Presidente: CALLER CELESTINO JACOBO. Con.Delegado: CALLER CELESTINO JACOBO. Datos registrales. T40626 , F 224, S 8, H M 381118, I/A 116 ( 8.06.23).

Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ PASTOR CARMEN. Apo.Sol.: LOPEZ PASTOR CARMEN. Apo.Manc.: LOPEZ PASTORCARMEN. Apoderado: PARDO DE ANDRADE FRANCISCO JAVIER GASPAR. Apo.Manc.: LOPEZ PASTOR CARMEN. Apo.Sol.:LOPEZ PASTOR CARMEN. Apo.Manc.: LOPEZ PASTOR CARMEN;LOPEZ PASTOR CARMEN;LOPEZ PASTOR CARMEN;LOPEZPASTOR CARMEN.Apoderado: MALLO SANCHEZ JAVIER EDUARDO;LOPEZ PASTOR CARMEN;LOPEZ PASTORCARMEN;MALLO SANCHEZ JAVIER EDUARDO;LOPEZ PASTOR CARMEN. Datos registrales. T 40626 , F 224, S 8, H M 381118,I/A 117 ( 8.06.23).

Nombramientos. Apoderado: BARRIO FERNANDEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 40626 , F 225, S 8, H M 381118, I/A 118 (8.06.23).

17 de Marzo de 2023
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40626 , F 222, S 8, H M 381118,I/A 113 (10.03.23).

27 de Diciembre de 2022
P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.fooddeliverybrands.com. Datosregistrales. T 40626 , F 222, S 8, H M 381118, I/A 112 (19.12.22).

21 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GASPAR PARDO DE ANDRADE JAVIER. Nombramientos. Secretario: ECHENIQUESANJURJO MANUEL. Vicesecret.: ATUTXA BERNAOLA GORKA. Datos registrales. T 40626 , F 221, S 8, H M 381118, I/A 111(12.04.22).

04 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 40626 , F 221, S 8, H M 381118, I/A 110 (30.01.22).

26 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: PARDO DE ANDRADE JAVIER GASPAR. Datos registrales. T 40626 , F 221, S 8, H M 381118, I/A 109(19.11.21).

10 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES MATEOS JESUS MARIA;CUBERO AYLLON JESUS MARIA;FERNANDEZ VALERAMIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: TORRES MATEOS JESUS MARIA;CUBERO AYLLON JESUS MARIA;FERNANDEZ VALERA MIGUELANGEL. Datos registrales. T 40626 , F 144, S 8, H M 381118, I/A 108 ( 3.08.21).

09 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ROBLES SOLE ALEJANDRO;SILVA RODRIGUEZ EVA MANUELA. Datos registrales. T 40626 , F 144,S 8, H M 381118, I/A 107 ( 2.08.21).

29 de Julio de 2021
Nombramientos. Presidente: TASTY BIDCO SL. Apoderado: CALLER CELESTINO JACOBO;MENDES DIOGO PEREIRA ANACARLA;RENEDO JIMENEZ JOSE LUIS;MALLO SANCHEZ JAVIER EDUARDO;MARTIN GARCIA IGNACIO;LOPEZ PASTORCARMEN. Datos registrales. T 40626 , F 143, S 8, H M 381118, I/A 106 (22.07.21).

26 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Presidente: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO.Nombramientos. Cons.: CULEBRAS YABAR VICTOR. Datos registrales. T 40626 , F 143, S 8, H M 381118, I/A 105 (19.07.21).

15 de Junio de 2021
Otros conceptos: SE REVOCA A PABLO JUANTEGUI AZPILICUETA EN LA INSCRIPCION 71陋. Datos registrales. T 40626 , F142, S 8, H M 381118, I/A 103M ( 4.06.21).

25 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Nombramientos. Con.Delegado: TASTY BIDCO SL.Datos registrales. T 40626 , F 142, S 8, H M 381118, I/A 104 (18.05.21).

17 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO;JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Apo.Sol.: JUANTEGUIAZPILICUETA PABLO. Apo.Manc.: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO;JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO;JUANTEGUIAZPILICUETA PABLO;JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO;JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Apoderado: JUANTEGUIAZPILICUETA PABLO. Nombramientos. Apoderado: CALLER CELESTINO JACOBO;RENEDO JIMENEZ JOSE LUIS;LOPEZPASTOR CARMEN;CALLER CELESTINO JACOBO;CALLER CELESTINO JACOBO. Datos registrales. T 40626 , F 137, S 8, H M381118, I/A 103 (10.05.21).

16 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIGEMOSE CHRISTIAN ANDERS. Datos registrales. T 40626 , F 137, S 8, H M 381118, I/A 101 (9.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DUGGINS DAVID. Datos registrales. T 40626 , F 137, S 8, H M 381118, I/A 102 ( 9.04.21).

13 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: FRAUCA AMORENA FERNANDO;FRAUCA AMORENA FERNANDO. Apo.Sol.: FRAUCA AMORENAFERNANDO. Apo.Manc.: FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;FRAUCA AMORENAFERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL. Apoderado: LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL. Apo.Man.Soli:GONZALEZ BARRAJON IGNACIO JAVIER. Apo.Manc.: FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTEMANUEL;FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;GONZALEZ BARRAJON IGNACIOJAVIER;FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;GONZALEZ BARRAJON IGNACIOJAVIER;FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;GONZALEZ BARRAJON IGNACIOJAVIER;FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;GONZALEZ BARRAJON IGNACIO JAVIER.Apoderado: FRAUCA AMORENA FERNANDO;LORING DIAZ DE BUSTAMANTE MANUEL;GONZALEZ BARRAJON IGNACIOJAVIER. Datos registrales. T 40626 , F 129, S 8, H M 381118, I/A 100 ( 6.04.21).

05 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: CULEBRAS YABAR VICTOR. Nombramientos. Representan: CALLER CELESTINO JACOBO.Datos registrales. T 40626 , F 129, S 8, H M 381118, I/A 99 (25.03.21).

04 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMERO GALAN MARIA DEL MAR. Apo.Manc.: ROMERO GALAN MARIA DEL MAR;ROMEROGALAN MARIA DEL MAR;ROMERO GALAN MARIA DEL MARApoderado: CASCALES DONES EDUARDO;ROMERO GALAN MARIADEL MAR. Datos registrales. T 40626 , F 128, S 8, H M 381118, I/A 98 (25.02.21).

18 de Enero de 2021
Nombramientos. Consejero: DUGGINS DAVID. Datos registrales. T 40626 , F 128, S 8, H M 381118, I/A 97 (11.01.21).

29 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 40626 , F 128, S 8, H M 381118, I/A 96 (21.12.20).

16 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Consejero: DIGEMOSE CHRISTIAN ANDERS. Datos registrales. T 40626 , F 127, S 8, H M 381118, I/A 95 (9.12.20).

03 de Noviembre de 2020
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Con.Ind.: DERKACH JOHN. Mbro.Cte.NyR: DERKACH JOHN. Nombramientos.Consejero: QUESTA GABRIELE. Reelecciones. Cons.Ejecuti: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Presidente: JUANTEGUIAZPILICUETA PABLO. Con.Delegado: JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO. Datos registrales. T 40626 , F 126, S 8, H M 381118, I/A93 (26.10.20).

Reelecciones. Consejero: TASTY BIDCO SL. Representan: CULEBRAS YABAR VICTOR. Datos registrales. T 40626 , F 127, S 8,H M 381118, I/A 94 (26.10.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n