Actos BORME de Forest Chemical Group Sa
05 de Octubre de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: TREEVALUE VEHICULO 1 SL;VEGA HORTELANOSERGIO;FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Secretario: TREEVALUE VEHICULO 1 SL. Vicepresid.: VEGA HORTELANO SERGIO.Presidente: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Datos registrales. T 4002 , F 140, S 8, H A 119306, I/A 16 C (28.09.23).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: ASESORES Y CONSULTORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES. Datos registrales. T 4002 , F 140, S8, H A 119306, I/A 20 ( 3.12.20).
13 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BUSINESS INNOVATION SL;INVERSIONES Y ASESORAMIENTO GREENFIELD SL. Datosregistrales. T 4002 , F 140, S 8, H A 119306, I/A 19 ( 5.03.20).
23 de Enero de 2017P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 4002 , F 140, S 8, H A 119306, I/A 18 (13.01.17).
20 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 105.187,00 Euros. Desembolsado: 105.187,00 Euros. Resultante Suscrito: 525.933,00 Euros.Resultante Desembolsado: 525.933,00 Euros. Datos registrales. T 4002 , F 140, S 8, H A 119306, I/A 17 (13.01.17).
17 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO;VEGA HORTELANO SERGIO. Nombramientos. Consejero:FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Presidente: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Consejero: VEGA HORTELANO SERGIO. Vicepresid.:
06 de Septiembre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ACTUACIONES QUIMICAS SL. Datos registrales. T 3566 , F 174, S 8, H A119306, I/A 15 (29.08.16).
01 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO;VEGA HORTELANO SERGIO;DIJKSTRA GOVERT COLIN;CAIXAINNVIERTE INDUSTRIA S.C.R. DE REGIMEN SIMPLI. Presidente: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Revocaciones. Auditor:DELOITTE SL. Nombramientos. Adm. Solid.: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO;VEGA HORTELANO SERGIO. Otros conceptos:Art铆culo de los estatutos: 14- Del Organo de administraci贸n. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 15. Plazo y retribuci贸n. Art铆culo de losestatutos: Articulo 16. Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 3566 , F 173, S 8, H A 119306, I/A 14 (23.09.15).
19 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: VILLARO PONTONES DAVID. Apo.Sol.: VILLARO PONTONES DAVID. Apo.Man.Soli: VEGAHORTELANO SERGIO;FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Nombramientos. Apo.Sol.: VEGA HORTELANO SERGIO;FERNANDEZCLIMENT PEDRO. Datos registrales. T 3566 , F 173, S 8, H A 119306, I/A 13 (11.05.15).
16 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 31.755,00 Euros. Desembolsado: 31.755,00 Euros. Resultante Suscrito: 420.746,00 Euros.Resultante Desembolsado: 420.746,00 Euros. Datos registrales. T 3566 , F 173, S 8, H A 119306, I/A 12 ( 5.09.14).
28 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 17.543,00 Euros. Desembolsado: 17.543,00 Euros. Resultante Suscrito: 388.991,00 Euros.Resultante Desembolsado: 388.991,00 Euros. Datos registrales. T 3416 , F 83, S 8, H A 119306, I/A 11 (20.01.14).
21 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3416 , F 83, S 8, H A 119306, I/A 10 (10.01.14).
30 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: VEGA HORTELANO SERGIO;FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Apo.Manc.: VILLARO PONTONESDAVID. Apo.Sol.: VILLARO PONTONES DAVID. Datos registrales. T 3416 , F 82, S 8, H A 119306, I/A 9 (20.09.13).
27 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VEGA HORTELANO SERGIO;FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Nombramientos. SecreNoConsj:PEREZ RODRIGO JUAN MANUEL. VsecrNoConsj: COMPANY REYNA ELENA. Consejero: FERNANDEZ CLIMENT PEDRO;VEGAHORTELANO SERGIO;DIJKSTRA GOVERT COLIN;CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA S.C.R. DE REGIMEN SIMPLI. Presidente:FERNANDEZ CLIMENT PEDRO. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 71.448,00 Euros. Desembolsado: 71.448,00 Euros. ResultanteSuscrito: 371.448,00 Euros. Resultante Desembolsado: 371.448,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 14- Del Organo deadministraci贸n.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.16. Deladministrador.21. Fuero. Datos registrales. T 3416 , F 36, S 8, H A 119306, I/A 8 (19.09.13).
26 de Septiembre de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 90.690,75 Euros. Datos registrales. T 3416 , F 36, S 8, H A 119306, I/A 7(18.09.13).
29 de Mayo de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 120.921,00 Euros. Desembolsado: 30.230,25 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 209.309,25 Euros. Datos registrales. T 3416 , F 36, S 8, H A 119306, I/A 6 (21.05.13).