Buscador CIF Logo

Actos BORME Forever Living Products Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Forever Living Products Spain Sl

Actos BORME Forever Living Products Spain Sl - B79235305

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Forever Living Products Spain Sl con CIF B79235305

馃敊 Perfil de Forever Living Products Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Forever Living Products Spain Sl

29 de Noviembre de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FOREVER LIVING PRODUCTS PORTUGAL-SAUDE E BELEZA LD. Datosregistrales. T 15420 , F 224, S 8, H M 83645, I/A 35 (22.11.23).

22 de Junio de 2023
Cambio de domicilio social. C/ MALDONADO 55 Esc.2 A (MADRID). Datos registrales. T 15420 , F 223, S 8, H M 83645, I/A 34(15.06.23).

26 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: DECOTTIGNIES PHILIPPE PAUL. Datos registrales. T 15420 , F 223, S 8, H M 83645, I/A 33(19.08.20).

07 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA ALFONSO JOAQUIN. Apo.Man.Soli: DECOTTIGNIES PHILIPPE PAUL;GARCIA ALFONSOJOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: DECOTTIGNIES PHILIPPE PAUL;DECOTTIGNIES PHILIPPE PAUL. Datos registrales. T15420 , F 222, S 8, H M 83645, I/A 32 (31.07.20).

30 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: CANALEJO CASTRILLERO MARIA DEL PILAR;GARCIA ALFONSO JOAQUIN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: DECOTTIGNIES PHILIPPE PAUL;GARCIA ALFONSO JOAQUIN;RODRIGUEZ CABEZUELO ALBERTO. Datosregistrales. T 15420 , F 221, S 8, H M 83645, I/A 31 (23.07.20).

04 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: MAUGHAN REX. Consejero: MAUGHAN REX. Secretario: MAUGHAN GREGG ELLIOTT.Nombramientos. Consejero: O'HARE AIDAN GEORGE. Secretario: O'HARE AIDAN GEORGE. Presidente: MAUGHAN GREGGELLIOTT. Datos registrales. T 15420 , F 221, S 8, H M 83645, I/A 30 (27.09.17).

17 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DIEZ DE VERGARA MAITANE. Datos registrales. T 15420 , F 221, S 8, H M 83645, I/A 29 (6.05.16).

12 de Febrero de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA COMANDANTE, FRANCO, 4 BLOQUE A. (MADRID). Datos registrales. T 15420 , F 220, S 8, HM 83645, I/A 28 ( 4.02.14).

26 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANTANA GONZALEZ LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 15420 , F 220, S 8, H M 83645, I/A 27(15.04.13).

06 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ALFONSO JOAQUIN. Datos registrales. T 15420 , F 219, S 8, H M 83645, I/A 26 (25.02.13).

25 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: LLOYD RJAY. Consejero: LLOYD RJAY. Revocaciones. Apoderado: BUSTILLO MU脩OZCRISTINA;RUBIO DIAZ DE ARCAUTE CARLOS ENRIQUE;LLOYD RJAY;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Nombramientos.Consejero: MAUGHAN GREGG ELLIOTT. Secretario: MAUGHAN GREGG ELLIOTT. Apo.Sol.: MAUGHAN GREGG ELLIOTT. Datosregistrales. T 15420 , F 218, S 8, H M 83645, I/A 25 (13.10.10).

12 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: NARVAEZ VEGA DE SEOANE PALOMA MARIA. Nombramientos. Apoderado: MAFUZ GUMIEL ROSAMARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 15420 , F 218, S 8, H M 83645, I/A 24(29.04.09).

20 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: MEDINA MONTOYA HELLGREN LUIS. Apo.Manc.: MEDINA MONTOYA HELLGREN LUIS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTANA GONZALEZ LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 15420 , F 218, S 8, H M 83645, I/A 23 (9.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n