Actos BORME de Forjados Riojanos Reciclados Sociedad Limitada
13 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PE脩A OCHAGAVIA CESAREO;VELEZ DEL RIO EDUARDO. Nombramientos. Adm. Unico:VELEZ DEL RIO EDUARDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 682 , F 212, S 8, H LO 12362, I/A 12 ( 6.03.18).
08 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: VELEZ FONTECHA ERNESTO;LAFUENTE LOPEZ MONSERRAT. Datos registrales. T 682 , F 212,S 8, H LO 12362, I/A 11 (31.08.16).
07 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VELEZ FONTECHA ERNESTO. Nombramientos. Adm. Mancom.: VELEZ DEL RIOEDUARDO. Datos registrales. T 682 , F 211, S 8, H LO 12362, I/A 10 (26.02.16).
09 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Presidente: JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Consejero:VELEZ FONTECHA ERNESTO. Secretario: VELEZ FONTECHA ERNESTO. Consejero: PE脩A OCHAGAVIA CESAREO.Nombramientos. Adm. Mancom.: PE脩A OCHAGAVIA CESAREO;VELEZ FONTECHA ERNESTO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 682 , F 211, S 8, H LO12362, I/A 9 (30.11.15).
24 de Enero de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FORJADOS RIOJANOS PREFABRICADOS SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 682 , F 210, S 8, H LO 12362, I/A 6 (17.01.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Presidente: JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Consejero:SAEZ FRANCIA ENRIQUE. Secretario: SAEZ FRANCIA ENRIQUE. Consejero: PEREZ RUIZ RAFAEL;PE脩A OCHAGAVIACESAREO;VELEZ FONTECHA ERNESTO. Nombramientos. Consejero: JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Presidente:JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO. Consejero: VELEZ FONTECHA ERNESTO. Secretario: VELEZ FONTECHA ERNESTO.Consejero: PE脩A OCHAGAVIA CESAREO. Datos registrales. T 682 , F 210, S 8, H LO 12362, I/A 7 (17.01.13).
Revocaciones. Apo.Manc.: SAEZ FRANCIA ENRIQUE;VELEZ FONTECHA ERNESTO;JIMENO MARTINEZ JUANALBERTO;PEREZ RUIZ RAFAEL;PE脩A OCHAGAVIA CESAREO. Nombramientos. Apo.Manc.: VELEZ FONTECHAERNESTO;JIMENO MARTINEZ JUAN ALBERTO;PE脩A OCHAGAVIA CESAREO. Datos registrales. T 682 , F 210, S 8, H LO12362, I/A 8 (17.01.13).
13 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: SAEZ FRANCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 682 , F 210, S 8, H LO 12362, I/A 5 ( 4.07.12).
30 de Abril de 2009Ampliacion del objeto social. La realizaci贸n de demoliciones, derribos y perforaciones de edificaciones y el reciclaje de residuos deconstrucci贸n, demolici贸n, materiales de desecho y escombro para la producci贸n, elaboraci贸n y venta de 谩ridos reciclados.El transportep煤blico de mercanc铆as por carretera y alquiler como servicio. Datos registrales. T 682 , F 209, S 8, H LO 12362, I/A 4 (20.04.09).
29 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: SAEZ FRANCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 682 , F 209, S 8, H LO 12362, I/A 3 (20.01.09).
12 de Enero de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: SAEZ FRANCIA ENRIQUE;VELEZ FONTECHA ERNESTO;JIMENO MARTINEZ JUANALBERTO;PEREZ RUIZ RAFAEL;PE脩A OCHAGAVIA CESAREO. Datos registrales. T 682 , F 208, S 8, H LO 12362, I/A 2(29.12.08).