Actos BORME de Formacion Seleccion Y Consultoria Sa
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 21575 , F 189, S 8, H M 31197, I/A 231(13.12.23).
27 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ JAIME BORJA. Datos registrales. T 21575 , F 188, S 8, H M 31197, I/A 230 (20.10.23).
31 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Apo.Man.Soli: RUBIO MERINO ANTONIO. Apoderado: RUBIO MERINOANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 188, S 8, H M 31197, I/A 229 (24.07.23).
17 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 21575 , F 188, S8, H M 31197, I/A 228 ( 9.05.23).
25 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 21575 , F 188, S 8, H M 31197, I/A227 (18.04.23).
21 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO. Datos registrales. T 21575 , F 188, S 8, H M 31197, I/A 226(14.04.23).
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 21575 , F 186, S 8, H M 31197, I/A 224 (30.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 21575 , F 187, S 8, H M 31197, I/A 225(30.03.23).
01 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: NA脩EZ PEREZ MANUEL;MARTINEZ DE UBAGO Y LI脩AN FERNANDO. Datos registrales. T 21575 , F186, S 8, H M 31197, I/A 223 (22.02.23).
17 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21575 , F 185, S 8, H M 31197, I/A222 (10.01.23).
04 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. L. Asesor: RUIZ DE LEON LORIGA IGNACIO JOSE. Datos registrales. T 21575 , F 185, S 8, H M 31197, I/A221 (28.12.22).
27 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 21575 , F 185, S 8, H M31197, I/A 220 (19.12.22).
13 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 21575 , F 183, S 8, H M31197, I/A 218 ( 2.12.22).
Revocaciones. Apoderado: POVEDA GIL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21575 , F 184, S 8, H M 31197, I/A 219 (2.12.22).
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: TEJEDOR TRANCA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 21575 , F 183, S 8, H M 31197, I/A 217(30.11.22).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 21575 , F 182, S 8, H M 31197, I/A 216 (20.10.22).
12 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 21575 , F 182, S 8, H M 31197, I/A 215 (5.08.22).
11 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 21575 , F 182, S 8, H M 31197, I/A 214 ( 4.08.22).
12 de Julio de 2022Otros conceptos: Ratificaci贸n del poder que caus贸 la inscripci贸n 210陋 y se inscribe su facultad 53.- Datos registrales. T 21575 , F181, S 8, H M 31197, I/A 213 ( 5.07.22).
13 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 21575 , F 180, S 8, H M 31197, I/A 212 (6.05.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: CALERO HERNAN MIGUEL ANGEL;MARTINEZ HERNANDEZ ANDRES;RABAT OLIVAJUAN;FERREIRO DIAZ RAMON;ALVAREZ SANCHEZ GRACIANO;GUT BELTRAMO HERBERTO JUAN;ESPINOSA URIARTEMARCOS;GARCIA GARCIA SANTIAGO;SANTISTEBAN LOPEZ JUAN MARCOS;VILANOVA PLANA JUAN;SOLANAS DE LA TORREEMILIO;ALVAREZ SANCHEZ GRACIANO. Apo.Sol.: GARCIA AGUSTIN JUAN ANDRES. Apoderado: LOZANO LOZANO DANIEL.Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANO JULIO. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO.Datos registrales. T 21575 , F 180, S 8, H M 31197, I/A 211 (17.02.22).
10 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21575 , F 177, S 8, H M 31197,I/A 210 ( 3.02.22).
05 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PROSEGUR SOLUCIONES SA;ESC SERVICIOS GENERALES SL. Representan: PEREAARRANZ PEDRO PABLO;MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ESC SERVICIOS GENERALES SL.Representan: MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 21575 , F 177, S 8, H M 31197, I/A 209 (29.12.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 21575 , F 176, S 8, H M 31197, I/A 208 ( 6.10.21).
23 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZ BARROSO JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 21575 , F 176, S 8, H M 31197, I/A207 (16.09.21).
04 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 21575 , F 174, S 8, H M 31197, I/A 206(28.07.21).
30 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 21575 , F 173, S 8, H M 31197, I/A 205(23.07.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DO脩A MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 21575 , F 172, S 8, H M 31197, I/A 204 ( 5.05.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 21575 , F 172, S 8, H M 31197, I/A 203(26.04.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 21575 , F 171, S 8, H M 31197, I/A 202(23.03.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 21575 ,F 169, S 8, H M 31197, I/A 200 (12.02.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 170, S 8, H M31197, I/A 201 (12.02.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 21575 , F 168, S 8, H M 31197, I/A 199(10.02.21).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 21575 ,F 167, S 8, H M 31197, I/A 198 (30.11.20).
03 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 21575 , F 167, S8, H M 31197, I/A 197 (26.11.20).
23 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ VALLEJO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 166, S 8, H M 31197, I/A 196(16.11.20).
08 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL;BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 21575 , F 165, S 8, H M31197, I/A 195 ( 1.10.20).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 21575 , F 165, S 8, H M 31197, I/A 194 ( 7.08.20).
12 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: PE脩A MELLADO ROBERTO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;PE脩A MELLADOROBERTO;MU脩OZ VALDES RAFAEL. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUEPEDRO. Datos registrales. T 21575 , F 164, S 8, H M 31197, I/A 193 ( 5.08.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZ ALBERTO;SANCHEZ DE COSANDRES;DIAZ HERVAS PEDRO;ZAHARIEVA ZORINA;RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 21575 , F 163, S 8, H M31197, I/A 192 ( 3.08.20).
04 de Agosto de 2020Reelecciones. Adm. Mancom.: PROSEGUR SOLUCIONES SA;ESC SERVICIOS GENERALES SL. Representan: MARTINCARRERA JUAN LUIS;PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 21575 , F 163, S 8, H M 31197, I/A 191 (28.07.20).
11 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA MARIANO. Datos registrales. T 21575 , F 161, S 8, H M 31197, I/A 189(29.11.19).
Modificaciones estatutarias. Aprobaci贸n de un nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales.-. Datos registrales. T 21575 , F161, S 8, H M 31197, I/A 190 ( 2.12.19).
09 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR. Datos registrales. T 21575 , F 160, S 8, H M31197, I/A 188 ( 2.08.19).
07 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: LOPEZ TOUZON JAVIER;OZALLA MARTHE LUIS FERNANDO;MINGUEZ YAGUEZ CARLOS;TROBATBESO JUAN ANTONIO;FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 21575 , F 160, S 8, H M 31197, I/A 187(31.07.19).
13 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 21575 , F 160, S 8, H M 31197, I/A 186 (6.06.19).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL. Nombramientos. Representan: PEREA ARRANZ PEDROPABLO. Datos registrales. T 21575 , F 157, S 8, H M 31197, I/A 184 ( 3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 21575 , F 157, S 8, H M 31197, I/A 185 (3.06.19).
28 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO.Datos registrales. T 21575 , F 155, S 8, H M 31197, I/A 183 (19.11.18).
06 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 21575 , F 155, S 8, H M 31197, I/A 182(29.08.18).
04 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Representan: MARTIN CARRERAJUAN LUIS. Datos registrales. T 21575 , F 155, S 8, H M 31197, I/A 181 (28.08.18).
06 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL. Datos registrales. T 21575 , F 155, S 8, H M 31197, I/A 180(30.07.18).
07 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR. Datos registrales. T 21575 , F 154, S 8, H M31197, I/A 179 (30.05.18).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 21575 , F 153, S 8, H M 31197, I/A178 ( 3.05.18).
29 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 151, S 8, H M31197, I/A 177 (22.11.17).
20 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Mediante diligencia presentada, se modifica el segundo apellido del apoderado, siendo su nombre correctocompleto, DON JULIO SAAVEDRA LLANO. Datos registrales. T 21575 , F 151, S 8, H M 31197, I/A 176 ( 8.11.17).
25 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: ORTIZ VAZQUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 21575 , F 151, S 8, H M 31197, I/A 175 (17.10.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BARRANCO AMARO PEDRO LUIS;POZO BARGUE脩O ESTEBAN;GIL MATAIX RAMON. Datosregistrales. T 21575 , F 150, S 8, H M 31197, I/A 174 (11.10.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE-CARLOS. Datos registrales. T 21575 , F 150, S 8, H M 31197, I/A173 ( 1.09.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 21575 , F 149, S 8, H M 31197, I/A 172 ( 9.08.17).
17 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: RUIZ SAN JUAN GUILLERMO. Apo.Man.Soli: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Apoderado: ESPA脩ACONTRERAS ANTONIO;ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 149, S 8, H M 31197, I/A 171 ( 6.07.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 21575 , F 148, S 8, H M 31197, I/A 170 (13.03.17).
03 de Noviembre de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS SL. Datos registrales. T21575 , F 148, S 8, H M 31197, I/A 169 (25.10.16).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 165陋, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPA脩A CONTRERAS. Datos registrales. T 21575, F 148, S 8, H M 31197, I/A 168 (22.07.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 21575 , F 147, S 8, H M 31197, I/A 167(15.07.16).
20 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: ENRIQUE ALONSO ENRIQUE. Datos registrales. T 21575 , F 147, S 8, H M 31197, I/A 166 (12.05.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 21575 , F 145, S 8, H M 31197, I/A 164(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 145, S 8, H M 31197, I/A 165(18.04.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 21575 , F145, S 8, H M 31197, I/A 163 (26.02.16).
05 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: ENRIQUE ALONSO ENRIQUE. Datos registrales. T 21575 , F 144, S 8, H M 31197, I/A 162(23.12.15).
30 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 142, S 8, H M 31197, I/A 160(21.12.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZ BARROSO JUAN BAUTISTA;REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 21575 , F143, S 8, H M 31197, I/A 161 (22.12.15).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 21575 , F 140, S 8, H M 31197, I/A 159 (18.12.15).
04 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;PE脩A MELLADO ROBERTO;RUBIO MERINOANTONIO;GARCIA SALIDO JOSE RICARDO;GARCIA PRIETO ALVARO. Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datosregistrales. T 21575 , F 139, S 8, H M 31197, I/A 158 (26.08.15).
08 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GUT REVOREDO CHRISTIAN;BANDRES GUTIERREZ MIGUEL. Nombramientos.Representan: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL;BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Adm. Mancom.: PROSEGUR ALARMASSA;ESC SERVICIOS GENERALES SL. Datos registrales. T 21575 , F 138, S 8, H M 31197, I/A 157 (30.06.15).
04 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: RUIZ MORENO JAVIER;ORO PRADERA LUIS. Datos registrales. T 21575 , F 138, S 8, H M 31197, I/A156 (24.02.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Datos registrales. T 21575 , F 136, S 8, H M 31197, I/A 155(24.02.15).
03 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: SUAREZ CANTON NICOLAS. Apo.Sol.: SUAREZ CANTON NICOLAS. Datos registrales. T 21575 , F136, S 8, H M 31197, I/A 153 (26.01.15).
Revocaciones. Apoderado: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Apo.Sol.: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T21575 , F 136, S 8, H M 31197, I/A 154 (27.01.15).
27 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: BLANCO JUAREZ PABLO. Datos registrales. T 21575 , F 136, S 8, H M 31197, I/A 152 (19.01.15).
27 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: GIMENO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 21575 , F 136, S 8, H M 31197, I/A 151 (19.08.14).
13 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 135, S 8, H M 31197, I/A 150 (5.08.14).
14 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: REVOREDO DELVECCHIO HELENA IRENE. Datos registrales. T 21575 , F 134, S 8, H M 31197, I/A149 ( 4.04.14).
20 de Diciembre de 2013Reelecciones. Adm. Mancom.: GUT REVOREDO CHRISTIAN;BANDRES GUTIERREZ MIGUEL. Datos registrales. T 21575 , F134, S 8, H M 31197, I/A 148 (13.12.13).
18 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: SAGUAR DUE脩AS ESTRELLA ISABEL. Datos registrales. T 21575 , F 134, S 8, H M 31197, I/A 147(10.06.13).
17 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 21575 , F 133,S 8, H M 31197, I/A 146 ( 7.06.13).
14 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 21575 , F 132, S 8, H M 31197, I/A 144 (6.06.13).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 21575 , F 133, S 8, H M 31197, I/A 145 (6.06.13).
11 de Marzo de 2013Revocaciones. Apoderado: COROMINAS MENENDEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 21575 , F 132, S 8, H M 31197, I/A 143(28.02.13).
22 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 21575 , F 131, S 8, H M 31197, I/A 142 (12.11.12).
16 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: SAGUAR DUE脩AS ESTRELLA ISABEL. Datos registrales. T 21575 , F 131, S 8, H M 31197, I/A 141 (4.07.12).
15 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: SOLANAS DE LA TORRE EMILIO. Datos registrales. T 21575 , F 131, S 8, H M 31197, I/A 140(31.03.11).
21 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ CANTON NICOLAS;LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T 21575 , F 131, S 8,H M 31197, I/A 139 ( 8.02.11).
11 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T 21575 , F 130, S 8, H M 31197, I/A 138(29.09.10).
21 de Mayo de 2010Otros conceptos: Ratificaci贸n ,en su totalidad, por el 贸rgano de administraci贸n del poder otorgado a don Miguel Soler Ru铆z-Boada enescritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Ram贸n Corral Beneyto , con n煤mero 126 de prtocolo , el 20 de enero de 2010,inscrito en este Registro Mercantil el 5 de abril de 2010. Datos registrales. T 21575 , F 129, S 8, H M 31197, I/A 137 (12.05.10).
Otros conceptos: Ratificaci贸n por el 贸rgano de administraci贸n del poder otorgado a do帽a Sagrario Fern谩ndez Barbe en escrituraotorgada ante el notario de Madrid, don Ram贸n Corral Beneyto, con n煤mero 125 de protocolo, el 20 de enero de 2010 , inscrito enesteRegistro Mercantil el 5 de abril de 2010. Datos registrales. T 21575 , F 129, S 8, H M 31197, I/A 136 (12.05.10).
19 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 21575 , F 124, S 8, H M 31197, I/A 134 (5.04.10).
Nombramientos. Apoderado: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL. Datos registrales. T 21575 , F 127, S 8, H M 31197, I/A 135 (5.04.10).
24 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: VILLANUEVA PEREZ JESUS ANGEL;MORENO ARENAS JUAN JOSE. Datos registrales. T 21575 , F124, S 8, H M 31197, I/A 133 (12.11.09).
04 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: CALVO SAEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 21575 , F 124, S 8, H M 31197, I/A 132 (22.10.09).
07 de Agosto de 2009Revocaciones. Apoderado: PLA VELARDE JAIME. Datos registrales. T 21575 , F 124, S 8, H M 31197, I/A 131 (28.07.09).
20 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: SUAREZ CANTON NICOLAS. Datos registrales. T 21575 , F 122, S 8, H M 31197, I/A 130 ( 8.07.09).
14 de Julio de 2009Revocaciones. Apoderado: VAL MAGALLON RAMIRO;GARCIA GARCIA SANTIAGO;GARCIA GARCIA SANTIAGO;GARCIAGARCIA SANTIAGO. Datos registrales. T 21575 , F 122, S 8, H M 31197, I/A 129 ( 2.07.09).
30 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 21575 , F 120, S 8, H M 31197, I/A 128 (19.06.09).
26 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: LOZANO LOZANO DANIEL. Datos registrales. T 21575 , F 119, S 8, H M 31197, I/A 127 (17.02.09).
16 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LOZANO LOZANO DANIEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: BANDRES GUTIERREZMIGUEL. Reelecciones. Adm. Mancom.: GUT REVOREDO CHRISTIAN. Datos registrales. T 21575 , F 119, S 8, H M 31197, I/A126 (24.12.08).