Actos BORME de Fornet Sl
24 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SALOME DEL-BA脩O CORBALAN. Datos registrales. T 2690 , F 27, S 8, H MU 71534, I/A 13(17.11.23).
11 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY. Presidente: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY. Consejero:FRANCISCO-JAVIER CANOVAS FORNET. Secretario: FRANCISCO-JAVIER CANOVAS FORNET. Consejero: JUANA FORNETSANCHEZ. Con.Delegado: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY. Cons.Del.Sol: JUANA FORNET SANCHEZ. Nombramientos. Adm.Unico: ANTONIO-LUIS FORNET CAMPOY. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. MODIFICAN EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. La Sociedadtendr谩 por objeto la compraventa, comercializaci贸n, instalaci贸n, reparaci贸n de m谩quinas de caf茅, molinillos, frigor铆ficas y maquinaria engeneral del ramo de alimentaci贸n y hosteler铆a, as铆 como sus componentes. Las activades enumeradas en el art铆culo anterior, podr谩nser realizadas por. Datos registrales. T 2690 , F 27, S 8, H MU 71534, I/A 12 ( 3.01.22).
24 de Agosto de 2018Nombramientos. Cons.Del.Sol: JUANA FORNET SANCHEZ. Datos registrales. T 2690 , F 26, S 8, H MU 71534, I/A 11 (17.08.18).
17 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUELA DE LOS REYES FORNET CAMPOY. Datos registrales. T 2690 , F 26, S 8, H MU 71534,I/A 10 (10.11.15).
25 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 65.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 125.216,00 Euros. Datos registrales. T 2690 , F 26, S 8, HMU 71534, I/A 9 (18.05.15).
14 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCISCA FORNET SANCHEZ. Revocaciones. Apo.Sol.: MARIO CANOVAS FORNET.Apoderado: MANUELA DE LOS REYES FORNET CAMPOY. Datos registrales. T 2690 , F 26, S 8, H MU 71534, I/A 8 ( 7.05.15).
16 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY;JUAN GARCIA MAYOR;JOSEFA ROS RUIZ. Datos registrales. T2690 , F 25, S 8, H MU 71534, I/A 7 ( 6.02.15).
18 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ANTONIO-LUIS FORNET CAMPOY. Nombramientos. Consejero: ANTONIO LUIS FORNETCAMPOY. Presidente: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY. Consejero: FRANCISCO-JAVIER CANOVAS FORNET. Secretario:FRANCISCO-JAVIER CANOVAS FORNET. Consejero: JUANA FORNET SANCHEZ;FRANCISCA FORNET SANCHEZ;MANUELA DELOS REYES FORNET CAMPOYCon.Delegado: ANTONIO LUIS FORNET CAMPOY. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otros conceptos: modificaci贸n del articulo 18 de losestatutos sociales. Datos registrales. T 2690 , F 25, S 8, H MU 71534, I/A 6 (12.04.13).
23 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: ISABEL MARIA FORNET CAMPOY. Datos registrales. T 2690 , F 18, S 8, H MU 71534, I/A 2(15.07.09).
Nombramientos. Apoderado: JOSE PE脩ALVER ALMELA. Datos registrales. T 2690 , F 18, S 8, H MU 71534, I/A 3 (15.07.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARIO CANOVAS FORNET;FRANCISCO-JAVIER CANOVAS FORNET. Datos registrales. T 2690 , F18, S 8, H MU 71534, I/A 4 (15.07.09).
Nombramientos. Apoderado: MANUELA DE LOS REYES FORNET CAMPOY. Datos registrales. T 2690 , F 19, S 8, H MU 71534,I/A 5 (15.07.09).
24 de Junio de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 4.05.09. Objeto social: La compraventa, comercializacion, instalacion y reparaci贸n dem谩quinas de caf茅, molinillos, frigor铆ficas y maquinaria en general del ramo de alimentaci贸n y hosteler铆a, asi como sus componentes.Domicilio: RONDA DE GARAY 4 BAJO - EDIFICIO "TRIUNFO" (MURCIA). Capital: 60.200,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico:ANTONIO-LUIS FORNET CAMPOY. Datos registrales. T 2690 , F 18, S 8, H MU 71534, I/A 1 (15.06.09).