Actos BORME de Fortem Integral Sociedad Limitada
13 de Abril de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2潞.-. Objeto social.-. Ampliacion del objeto social. Impartir toda clase decursos de formaci贸n te贸ricos y/op pr谩cticos acerca de la prevci贸no extinci贸n de fuegos, inundaciones, avalanchas, corrimiento detierras y cualesquiera otros accidentes provocados por causas naturales o por la intervenci贸n humana, as铆 como de actuaci贸n frenta aestas circunsta. Datos registrales. T 27923 , F 196, S 8, H M 372679, I/A 22 ( 6.04.22).
07 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS. Nombramientos. SecreNoConsj: GUERREROMORENO MARIA ANGELES ASUNCION. Datos registrales. T 27923 , F 196, S 8, H M 372679, I/A 21 (31.01.19).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ SIDERA JUAN LUIS. Datos registrales. T 27923 , F 194, S 8, H M 372679, I/A 20 (5.01.18).
12 de Agosto de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTINA VIRGINIA ANASTASIA;CARPINTERO GRANDE MARIA. Datos registrales. T27923 , F 193, S 8, H M 372679, I/A 19 ( 4.08.16).
27 de Enero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 35.896,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.030,00 Euros. Datos registrales. T 27923 , F 192, S 8, HM 372679, I/A 18 (19.01.16).
27 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPINTERO GRANDE CARLOS;GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS;GUERRERO MORENOMARIA ANGELES ASUNCION. Presidente: CARPINTERO GRANDE CARLOS. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE CARLOS.Secretario: GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS. Nombramientos. Consejero: CARPINTERO GRANDE CARLOS;FERNANDEZMOYA EUGENIO;ROJO CANIEGO ALBERTO ANGEL. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE CARLOS. Presidente: CARPINTEROGRANDE CARLOS. SecreNoConsj: GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS. Datos registrales. T 27923 , F 192, S 8, H M 372679, I/A17 (17.04.15).
13 de Agosto de 2013Cambio de domicilio social. AVDA ENSANCHE DE VALLECAS NUMERO 44 (MADRID). Datos registrales. T 27923 , F 190, S 8,H M 372679, I/A 15 ( 5.08.13).
Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO GRANDE SARA. Datos registrales. T 27923 , F 190, S 8, H M 372679, I/A 16 (5.08.13).
23 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE DIAZ GONZALO. Datos registrales. T 27923 , F 190, S 8, H M 372679, I/A 14(16.05.13).
06 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES HERNANDEZ MARCOS ANTONIO. Presidente: ROBLES HERNANDEZ MARCOSANTONIO. Consejero: CIVERA HERRAIZ JOSE LUIS;CARPINTERO GRANDE CARLOS;GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS.Secretario: GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS. Con.Delegado: ROBLES HERNANDEZ MARCOS ANTONIO. Nombramientos.Consejero: CARPINTERO GRANDE CARLOS;GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS;GUERRERO MORENO MARIA ANGELESASUNCION. Presidente: CARPINTERO GRANDE CARLOS. Con.Delegado: CARPINTERO GRANDE CARLOS. Secretario: GOMEZAGUILERA ANGEL MARCOS. Datos registrales. T 21010 , F 151, S 8, H M 372679, I/A 13 (27.07.10).
12 de Marzo de 2010Cambio de domicilio social. C/ BERLIN, NUMERO 7, 7潞 DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 21010 , F 151, S 8, H M372679, I/A 12 ( 2.03.10).
01 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 64.134,00 Euros. Datos registrales. T 21010 , F 150, S 8, HM 372679, I/A 11 (20.05.09).
28 de Abril de 2009Ampliacion del objeto social. IMPARTIR TODA CLASE DE CURSOS DE FORMACION TEORICOS Y/O PRACTICOS ACERCA DELA PREVENCIO O EXTINCION DE FUEGOS, INUNDACIONES, AVALANCHAS, CORRIMIENTODE TIERRAS. Datos registrales. T21010 , F 150, S 8, H M 372679, I/A 10 (16.04.09).