Actos BORME de Fotojumilla 4 Sl
25 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: VILAPLANA RUIZ JORGE;APARICIO CRESPO JOSE IGNACIO;ARIAS ECHEVERRIAGONZALO;GARCIA RODRIGUEZ EMILIO JOSE;VEGA MARCOS JORDI;ARKIPOFF IVAN;PEÑARRUBIA SANCHEZSALVADOR;BUSTAMANTE ABAD NATALIA;DE LA ROSA ORDOÑEZ MARTA;ROSADO SIBON EDUARDO;DE LA CRUZ AGUILLOJAVIER;VELON NAVARRO ANA;SANCHEZ PEÑARRUBIA FRANCISCO. Datos registrales. T 24193 , F 101, S 8, H M 434763, I/A 8(18.11.22).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: PEÑARRUBIA SANCHEZ SALVADOR. Datos registrales. T 24193 , F 98, S 8, H M 434763, I/A 7(14.11.22).
19 de Agosto de 2021Cambio de domicilio social. AVDA DE LA TRANSICION ESPAÑOLA 32 - PARQUE EMPRESA (ALCOBENDAS). Datosregistrales. T 24193 , F 98, S 8, H M 434763, I/A 6 (12.08.21).
25 de Junio de 2014Cambio de domicilio social. C/ SEPULVEDA 17, BAJO 1-2 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 24193 , F 98, S 8, H M 434763,I/A 5 (16.06.14).
26 de Octubre de 2011Cambio de domicilio social. C/ COSTA BRAVA 13 3º B (MADRID). Datos registrales. T 24193 , F 98, S 8, H M 434763, I/A 4(13.10.11).
23 de Octubre de 2009Cambio de domicilio social. C/ NURIA 59 2º B (MADRID). Datos registrales. T 24193 , F 97, S 8, H M 434763, I/A 3 (13.10.09).