Buscador CIF Logo

Actos BORME Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada

Actos BORME Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada - B91699348

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada con CIF B91699348

馃敊 Perfil de Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fotovoltaica De Cantillana 04 Sociedad Limitada

20 de Diciembre de 2016
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 26585 , F 33, S 8, H M 479106, I/A 8 (12.12.16).

31 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: LABOURET ALEXANDRE;MULLIEZ LAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE. Presidente:MULLIEZ LAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE. Co.De.Ma.So: MULLIEZ LAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE.Consejero: JARDINE SIMON;DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Co.De.Ma.So: JARDINE SIMON;LABOURET ALEXANDRE. Cons.Del.Sol:DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Secretario: JARDINE SIMON. Vicesecret.: DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico:ANEMOI CANTILLANA SL. Representan: LABOURET ALEXANDRE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. GTA DE RUBEN DARIO 3 1潞 -DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 26585 , F 32, S 8, H M 479106, I/A 7 (19.12.13).

24 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Apo.Man.Soli: ELLIOTT JOHN. Apo.Manc.: CIRILLORICCARDO;LABOURET ALEXANDRE. Datos registrales. T 26585 , F 32, S 8, H M 479106, I/A 6 (16.09.13).

09 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUNTIN IBARRA JUAN MIGUEL;MENENDEZ ELVIRA EMILIO. Presidente: LABOURETALEXANDRE. Secretario: MENENDEZ ELVIRA EMILIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUNTIN IBARRA JUAN MIGUEL.Apoderado: LABOURET ALEXANDRE;GUNTIN IBARRA JUAN MIGUEL. Nombramientos. Consejero: MULLIEZ LAURENCEBLANCHE LUCETTE ELEONORE. Presidente: MULLIEZ LAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE. Co.De.Ma.So: MULLIEZLAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE. Consejero: JARDINE SIMON;DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Co.De.Ma.So: JARDINESIMON;LABOURET ALEXANDRE. Cons.Del.Sol: DIAZ GONZALEZ ALBERTO. Secretario: JARDINE SIMON. Vicesecret.: DIAZGONZALEZ ALBERTO. Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON JOSEPH MUTHUENESCRITURA DEL NOTARIO DON CARLOS DE PRADA EL 14 DE MAYO DE2008 CON EL NUMERO 1033 DE PROTOCOLO.Cambio de domicilio social. AVDA DE BRASIL 17 12 FG (MADRID). Datos registrales. T 26585 , F 30, S 8, H M 479106, I/A 5(26.03.12).

15 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MENENDEZ ELVIRA EMILIO. Nombramientos. Apoderado: LABOURET ALEXANDRE;MULLIEZLAURENCE BLANCHE LUCETTE ELEONORE;GUNTIN IBARRA JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 26585 , F 30, S 8, H M479106, I/A 4 ( 2.09.11).

13 de Abril de 2009
Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO 377 5潞 (MADRID). Datos registrales. T 26585 , F 30, S 8, H M 479106, I/A 2(30.03.09).

Cambio de domicilio social. AVDA DEL BRASIL 17 2潞 A Y B (MADRID). Datos registrales. T 26585 , F 30, S 8, H M 479106, I/A 3(30.03.09).

26 de Marzo de 2009
Otros conceptos: Expedida Nueva certificaci贸n de traslado de domicilio a MADRID por caducidad de la anterior que fue expedida eld铆a 25 de septiembre de 2008.- Datos registrales. T 4830 , F 165, S 8, H SE 77262, I/A 4 B ( 9.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n